PACER CATS (UK) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PACER CATS (UK) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04732109 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PACER CATS (UK) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Sovereign House C/O M-Hance Limited Stockport Road SK8 2EA Cheadle |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PACER CATS (UK) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 29 sept. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour PACER CATS (UK) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 29 sept. 2021 | 9 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Victoria Anne Chandler en tant que secrétaire le 07 sept. 2022 | 1 pages | TM02 | ||
Changement d'adresse du siège social de The Square Basing View Basingstoke RG21 4EB England à Sovereign House C/O M-Hance Limited Stockport Road Cheadle SK8 2EA le 26 août 2022 | 2 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 avr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré The Square Basing View Basingstoke RG21 4EB | 1 pages | AD04 | ||
Changement d'adresse du siège social de Suite 29, 80 Churchill Square Kings Hill West Malling ME19 4YU England à The Square Basing View Basingstoke RG21 4EB le 05 janv. 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 29 sept. 2020 | 13 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 avr. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Mel David Taylor en tant que directeur le 16 avr. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Alan John Moody en tant qu'administrateur le 17 avr. 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré The Square Basing View Basingstoke RG21 4EB | 1 pages | AD03 | ||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à The Square Basing View Basingstoke RG21 4EB | 1 pages | AD02 | ||
Changement d'adresse du siège social de 200 Cedarwood, Crockford Lane Chineham Business Park Basingstoke RG24 8WD England à Suite 29, 80 Churchill Square Kings Hill West Malling ME19 4YU le 15 mars 2021 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 29 sept. 2019 | 13 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 avr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 29 sept. 2018 | 13 pages | AA | ||
Nomination de Mr Nicholas Julian Bratton en tant qu'administrateur le 01 mai 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Oliver Carl Archer en tant que directeur le 30 avr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 avr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 29 sept. 2017 | 13 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 avr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 29 sept. 2016 | 12 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 avr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de PACER CATS (UK) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRATTON, Nicholas Julian | Administrateur | C/O M-Hance Limited Stockport Road SK8 2EA Cheadle Sovereign House | United Kingdom | British | 248433320001 | |||||
| MOODY, Alan John | Administrateur | C/O M-Hance Limited Stockport Road SK8 2EA Cheadle Sovereign House | England | British | 245409680001 | |||||
| ARNOLD, Richard Stewart | Secrétaire | Palmer Road SP2 7LX Salisbury 5 Wiltshire | British | 60617500004 | ||||||
| CHANDLER, Victoria Anne | Secrétaire | C/O M-Hance Limited Stockport Road SK8 2EA Cheadle Sovereign House | 212445980001 | |||||||
| MCDERMOTT, Thomas Paul | Secrétaire | Newitt Place SO16 7FA Southampton 33 Hampshire | British | 134045580002 | ||||||
| SADLER, Stephen | Secrétaire | Hatch Warren Lane Hatch Warren RG22 4RA Basingstoke Paterson House Hatch Warren Farm Hampshire | 158470660001 | |||||||
| WARWICK-SAUNDERS, Richard Meirion | Secrétaire | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | 165681630001 | |||||||
| HAMMONDS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 900026750001 | |||||||
| ARCHER, Oliver Carl | Administrateur | Cedarwood, Crockford Lane Chineham Business Park RG24 8WD Basingstoke 200 England | England | British | 150218430001 | |||||
| ASPLIN, Robert Alexander | Administrateur | Hatch Warren Lane Hatch Warren RG22 4RA Basingstoke Paterson House Hatch Warren Farm Hampshire | Uk | British | 149870270001 | |||||
| BOUZAC, Thierry Georges | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | England | French | 87674390003 | |||||
| GIBBON, David Keith Christopher | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | England | British | 49959390002 | |||||
| GOULD, Stephen | Administrateur | Woodleigh Monk Sherborne Road Ramsdell RG26 5PR Basingstoke Hampshire | British | 40197530001 | ||||||
| SADLER, Stephen Paul | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | England | British | 90689640003 | |||||
| SMITH, Kenneth Ronald | Administrateur | Telconia Close Headley Down GU35 8ED Bordon 7 Hampshire | United Kingdom | British | 34793900002 | |||||
| TAYLOR, Mel David | Administrateur | Churchill Square Kings Hill ME19 4YU West Malling Suite 29, 80 England | England | English | 203242420001 | |||||
| TEE, Fiona | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 66385440005 | |||||
| TIMOTHY, Fiona Maria | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | England | British | 161343370001 | |||||
| WALKER, Peter John | Administrateur | Tring Road HP23 4NU Wilstone 21 Herts | England | British | 128277860001 | |||||
| WRIGHT, Alan Stanley | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire | England | British | 83067060001 | |||||
| YORK, Graham | Administrateur | Glebe House Ashmore SP5 5AE Shaftsbury Wiltshire | England | English | 91383980001 | |||||
| HAMMONDS DIRECTORS LIMITED | Administrateur désigné | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 900026740001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PACER CATS (UK) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnico Group Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Cedarwood, Crockford Lane Chineham Business Park RG24 8WD Basingstoke 200 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
PACER CATS (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 18 sept. 2012 Livré le 25 sept. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 06 août 2003 Livré le 09 août 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0