ALCHEMY ENVIRONMENTAL LIMITED

ALCHEMY ENVIRONMENTAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALCHEMY ENVIRONMENTAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04734601
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALCHEMY ENVIRONMENTAL LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe ALCHEMY ENVIRONMENTAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Capstone House Prospect Park
    Dunston Way Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Derbyshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALCHEMY ENVIRONMENTAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EVER 2079 LIMITED15 avr. 200315 avr. 2003

    Quels sont les derniers comptes de ALCHEMY ENVIRONMENTAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ALCHEMY ENVIRONMENTAL LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ALCHEMY ENVIRONMENTAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 avr. 2015

    État du capital au 16 avr. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Amanda Jane Phoenix en tant que directeur le 07 août 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 avr. 2014

    État du capital au 17 avr. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    13 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher John Phoenix le 16 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Amanda Jane Phoenix le 16 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Robert Arnold Veerman le 16 nov. 2009

    1 pagesCH03

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    13 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    15 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de ALCHEMY ENVIRONMENTAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VEERMAN, Robert Arnold
    Capstone House Prospect Park
    Dunston Way Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Derbyshire
    Secrétaire
    Capstone House Prospect Park
    Dunston Way Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Derbyshire
    Dutch144829040001
    PHOENIX, Christopher John
    Capstone House Prospect Park
    Dunston Way Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Derbyshire
    Administrateur
    Capstone House Prospect Park
    Dunston Way Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Director16220320001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Secrétaire désigné
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023530001
    PHOENIX, Amanda Jane
    Capstone House Prospect Park
    Dunston Way Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Derbyshire
    Administrateur
    Capstone House Prospect Park
    Dunston Way Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Derbyshire
    United KingdomBritishLawyer111217890001
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Administrateur désigné
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023520001

    ALCHEMY ENVIRONMENTAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 30 mars 2007
    Livré le 16 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the north west and south east sides of buttermilk lane bolsover t/nos DY281634 DY360306. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 30 mars 2007
    Livré le 07 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Chattel mortgage
    Créé le 31 mars 2005
    Livré le 06 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The stock of washed coalite carpet situated at buttermilk lane bolsover. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ever 1813 Limited
    Transactions
    • 06 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 24 nov. 2003
    Livré le 26 nov. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ever 1813 Limited as Agent and Trustee for Itself and Each of the Secured Parties
    Transactions
    • 26 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 févr. 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0