FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED

FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFRASERS VINCENT SQUARE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04734907
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED ?

    • Administration de biens immobiliers pour compte de tiers (68320) / Activités immobilières

    Où se situe FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    81 Cromwell Road
    London
    SW7 5BW
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FAIRPOINT PROPERTIES (VINCENT SQUARE) LIMITED15 avr. 200315 avr. 2003

    Quels sont les derniers comptes de FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 juin 2015

    État du capital au 23 juin 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2014

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2013

    12 pagesAA

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 juin 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 05 juin 2013

    SH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2012

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2011

    12 pagesAA

    Cessation de la nomination de Valsec Company Secretarial Services Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Seng Khoon Ng le 15 avr. 2011

    1 pagesCH03

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    19 pagesMG01

    Nomination de Valsec Company Secretarial Services Limited en tant que secrétaire

    3 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Valad Secretarial Services Limited en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2009

    12 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NG, Seng Khoon
    81 Cromwell Road
    London
    SW7 5BW
    Secrétaire
    81 Cromwell Road
    London
    SW7 5BW
    British90211410001
    CHIA, Khong Shoong
    Alexandra Road
    # 21-00 Alexandra Point
    438
    Singapore 119958
    Administrateur
    Alexandra Road
    # 21-00 Alexandra Point
    438
    Singapore 119958
    SingaporeSingaporean141112510002
    LEAR, Simon John Patrick
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Administrateur
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    United KingdomBritish138750860001
    QUEK, Stanley Swee Han, Dr
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Administrateur
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    SingaporeSingaporean123800250001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Secrétaire
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    British812680001
    MCS FORMATIONS LIMITED
    235 Old Marylebone Road
    NW1 5QT London
    Secrétaire
    235 Old Marylebone Road
    NW1 5QT London
    69736830002
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    Secrétaire
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC219311
    133355520001
    VALSEC COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Secrétaire
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement7307485
    154204150001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Administrateur
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    UkBritish812680001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Administrateur
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    UkBritish812680001
    CHEONG, Anthony Fook Seng
    263 River Valley Road
    No 13-20 Aspen Hegihts
    FOREIGN Singapore
    238309
    Singapore
    Administrateur
    263 River Valley Road
    No 13-20 Aspen Hegihts
    FOREIGN Singapore
    238309
    Singapore
    Malaysian77121980001
    DODWELL, John Christopher
    1 Stable House Hope Wharf
    St Mary Church Street Rotherhithe
    SE16 4JX London
    Administrateur
    1 Stable House Hope Wharf
    St Mary Church Street Rotherhithe
    SE16 4JX London
    United KingdomBritish95741610002
    HENG, Jeffrey Wah Yong
    60 Chuan Garden
    FOREIGN Singapore
    558570
    Singapore
    Administrateur
    60 Chuan Garden
    FOREIGN Singapore
    558570
    Singapore
    Singaporean70088270001
    LEAR, Simon John Patrick
    2 Orchard Road
    TW1 1LY St Margarets
    Middlesex
    Administrateur
    2 Orchard Road
    TW1 1LY St Margarets
    Middlesex
    United KingdomBritish107485520001
    LIM, Ee Seng
    56 Lorong Melayu
    Sinapore
    416942
    Administrateur
    56 Lorong Melayu
    Sinapore
    416942
    SingaporeanSingaporean123920850001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    NG, Seng Khoon
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    Administrateur
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    EnglandBritish90211410001
    VAN REYK, Philip
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    Administrateur
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    EnglandBritish76943220003
    MCS INCORPORATIONS LIMITED
    235 Old Marylebone Road
    NW1 5QT London
    Administrateur
    235 Old Marylebone Road
    NW1 5QT London
    69737020001

    FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 23 déc. 2010
    Livré le 31 déc. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company each obligor investor or the investors' guarantor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 31 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment
    Créé le 19 juil. 2006
    Livré le 22 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The entire right title and interest in and to the specific contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 29 mai 2003
    Livré le 10 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property situate at 63-69 (odd) rochester row and 68 vincent square london SW1 title number NGL785625. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 mai 2003
    Livré le 10 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0