OLDVINE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOLDVINE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04750376
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OLDVINE LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe OLDVINE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OLDVINE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DUNWILCO (1055) LIMITED01 mai 200301 mai 2003

    Quels sont les derniers comptes de OLDVINE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour OLDVINE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    14 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 avr. 2018

    13 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 avr. 2017

    12 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 avr. 2016

    8 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de 33 18th Floor Cavendish Square London W1G 0PW à 4 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells Kent TN1 1EE le 07 mai 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 10 avr. 2015

    LRESSP

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2015

    AA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 21 nov. 2014

    • Capital: GBP 947,307
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Stephane Abraham Joseph Nahum en tant que directeur le 01 mai 2014

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Malcolm Robin Turner en tant que directeur le 01 mai 2014

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James Cairns Mcmahon en tant que directeur le 01 mai 2014

    2 pagesTM01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 13 nov. 2014

    • Capital: GBP 947,307
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 mai 2014

    État du capital au 21 mai 2014

    • Capital: GBP 20,250,000
    SH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de OLDVINE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHRISTOFI, Christakis, Mr.
    10 Litchfield Way
    NW11 6NJ London
    Secrétaire
    10 Litchfield Way
    NW11 6NJ London
    BritishFinance Director67125820002
    MCCABE, Gary John
    Cleuch Avenue
    North Middleton
    EH23 4RP Gorebridge
    6
    Midlothian
    Administrateur
    Cleuch Avenue
    North Middleton
    EH23 4RP Gorebridge
    6
    Midlothian
    ScotlandBritishBanker139525550001
    SCOTT, Keith
    Clarendon Road
    HP16 0PL Prestwood
    Michaelmas Farm
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Clarendon Road
    HP16 0PL Prestwood
    Michaelmas Farm
    Buckinghamshire
    BritishAccountant141163370001
    D.W. COMPANY SERVICES LIMITED
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    Secrétaire désigné
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    900004640001
    ANDERSON, Bruce Smith
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    Administrateur
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    ScotlandBritishBanker73849040001
    BAKER, David Leon
    14 Nottingham Terrace
    Regents Park
    NW1 4QB London
    Administrateur
    14 Nottingham Terrace
    Regents Park
    NW1 4QB London
    EnglandBritishChartered Surveyor46822620002
    HEWITT, Alistair James Neil
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandBritishDirector113081830001
    KASCH, Peter Carwile
    Filston Oast
    Filston Lane
    TN14 5JU Shoreham
    Kent
    Administrateur
    Filston Oast
    Filston Lane
    TN14 5JU Shoreham
    Kent
    United KingdomBritishSurveyor61386600003
    KERR, Donald
    28 Burnbank
    EH20 9NE Straiton
    Midlothian
    Administrateur
    28 Burnbank
    EH20 9NE Straiton
    Midlothian
    BritishBanker84247450001
    MACKINTOSH, Iain Stewart
    9 Greenbank Terrace
    EH10 6ER Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    9 Greenbank Terrace
    EH10 6ER Edinburgh
    Midlothian
    BritishChartered Accountant94163020001
    MCMAHON, James Cairns
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    Administrateur
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    ScotlandScottishCompany Director159708270001
    NAHUM, Stephane Abraham Joseph
    21a Kensington High Street
    W8 5NP London
    Administrateur
    21a Kensington High Street
    W8 5NP London
    EnglandFrenchPrivate Equity99292580003
    SELLAR, Gillian Christine
    112 Seaview Terrace
    EH15 2HQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    112 Seaview Terrace
    EH15 2HQ Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor107180940001
    TRIBE, Nicholas John Grove
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    Administrateur
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritishSurveyor141163390001
    TURNER, Malcolm Robin
    18 Jay Mews
    SW7 2EP London
    Administrateur
    18 Jay Mews
    SW7 2EP London
    United KingdomBritishChartered Surveyor60293070001
    D.W. DIRECTOR 1 LIMITED
    4th Floor
    Saltire Court, 20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    Administrateur désigné
    4th Floor
    Saltire Court, 20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    900021330001
    D.W. DIRECTOR 2 LIMITED
    4th Floor
    Saltire Court, 20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    Administrateur désigné
    4th Floor
    Saltire Court, 20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    900021320001

    OLDVINE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 04 mars 2004
    Livré le 19 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of a first floating charge the whole property (including uncalled capital) which is or may be from time to time comprised in the property and undertaking of the charge.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee and Agent for the Financeparties
    Transactions
    • 19 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 juil. 2003
    Livré le 02 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the security trustee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee and Agentfor the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 02 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    OLDVINE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 avr. 2015Commencement of winding up
    08 nov. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Newman
    Crowe U.K. Llp 4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    practitioner
    Crowe U.K. Llp 4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Vincent John Green
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    practitioner
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0