HUDDERSFIELD 2 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHUDDERSFIELD 2 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04769176
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HUDDERSFIELD 2 LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe HUDDERSFIELD 2 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 St Peter's Square
    M2 3EY Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de HUDDERSFIELD 2 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour HUDDERSFIELD 2 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    47 pagesWU15

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    47 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    45 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    44 pagesWU07

    Changement d'adresse du siège social de C/O Ernst & Young Llp 100 Barbirolli Square Manchester M2 3EY à 2 st Peter's Square Manchester M2 3EY le 10 août 2017

    2 pagesAD01

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:progress report brought down to 24/06/16 resignation of t a jack
    42 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:re progress report 25/02/2015-24/02/2016
    41 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:liquidator's annual progress report - compulsory liquidation - b/d date - 24/02/2015
    42 pagesLIQ MISC

    Nomination d'un liquidateur

    1 pages4.31

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    3 pagesCOCOMP

    Avis d'ordonnance du tribunal pour mettre fin à l'administration

    52 pages2.33B

    Ordonnance du tribunal avis de liquidation

    1 pagesF14

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 31 janv. 2014

    46 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 11 sept. 2013

    62 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    117 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    5 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Opal Property Group the Place Ducie Street Manchester M1 2TP* le 18 mars 2013

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2012

    18 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2011

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2012

    État du capital au 15 juin 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HUDDERSFIELD 2 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MELLOR, Craig Allan
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    Secrétaire
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    British60906780002
    DUNCAN, Gavin Robert
    St Peter's Square
    M2 3EY Manchester
    2
    Administrateur
    St Peter's Square
    M2 3EY Manchester
    2
    EnglandBritishDirector151512820001
    MELLOR, Craig Allan
    St Peter's Square
    M2 3EY Manchester
    2
    Administrateur
    St Peter's Square
    M2 3EY Manchester
    2
    EnglandBritishDirector60906780002
    WALL, Stuart Barrie
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector95010340001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secrétaire désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    MARTIN, Graham Hunter
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    BritishDirector87259480001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Administrateur désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    HUDDERSFIELD 2 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 23 mai 2005
    Livré le 28 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Little aspley hall 88 firth street and upper aspley mills firth street huddersfield t/no yk 8832. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Security assignment
    Créé le 15 sept. 2003
    Livré le 23 sept. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of security assignment all that the full benefit of a performance band dated 15 september 2003 issued by heath lambert limited.
    Personnes ayant droit
    • Ahli United Bank (UK) PLC
    Transactions
    • 23 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 15 sept. 2003
    Livré le 23 sept. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first floating charge all the undertaking and assets whatsoever and wheresoever both present and future.
    Personnes ayant droit
    • Ahli United Bank (UK) PLC
    Transactions
    • 23 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 15 sept. 2003
    Livré le 23 sept. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that l/h property briefly k/a 88 firth street and upper ashley mills firth street huddersfield t/no YK8832 and all right title and interest in all the rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ahli United Bank (UK) PLC
    Transactions
    • 23 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)

    HUDDERSFIELD 2 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    25 févr. 2014Administration ended
    12 mars 2013Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alan Robert Bloom
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Samuel James Woodward
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    2
    DateType
    25 févr. 2014Commencement of winding up
    13 sept. 2019Conclusion of winding up
    20 févr. 2020Dissolved on
    10 févr. 2014Petition date
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alan Robert Bloom
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samuel James Woodward
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    practitioner
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0