SALLY LYNCH COMMUNITY CARE ENTERPRISES LIMITED

SALLY LYNCH COMMUNITY CARE ENTERPRISES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSALLY LYNCH COMMUNITY CARE ENTERPRISES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04780844
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SALLY LYNCH COMMUNITY CARE ENTERPRISES LIMITED ?

    • Activités de soins résidentiels pour les personnes âgées et handicapées (87300) / Activités de santé humaine et d'action sociale
    • Autres activités de travail social sans hébergement n.c.a. (88990) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe SALLY LYNCH COMMUNITY CARE ENTERPRISES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SALLY LYNCH COMMUNITY CARE ENTERPRISES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour SALLY LYNCH COMMUNITY CARE ENTERPRISES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Satisfaction de la charge 047808440008 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 047808440009 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 047808440010 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Notification de Consensus Support Services en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Cessation de Paul Anthony Keith Jeffery en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    1 pagesPSC07

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 mai 2016

    État du capital au 31 mai 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 juin 2015

    État du capital au 01 juin 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 juin 2014

    État du capital au 05 juin 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    17 pagesAA

    Inscription de la charge 047808440010

    78 pagesMR01

    Inscription de la charge 047808440009

    53 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de SALLY LYNCH COMMUNITY CARE ENTERPRISES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Bradbury House 830
    Essex
    Secrétaire
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Bradbury House 830
    Essex
    BritishLegal Director52338530002
    HILL, Peter Martin
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Bradbury House 830
    Essex
    Administrateur
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Bradbury House 830
    Essex
    EnglandBritishAccountant130983750002
    JEFFERY, Paul Anthony Keith
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Bradbury House 830
    Essex
    Administrateur
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Bradbury House 830
    Essex
    United KingdomBritishAccountant65609290003
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Bradbury House 830
    Essex
    Administrateur
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Bradbury House 830
    Essex
    United KingdomBritishSolicitor148139420001
    MORGAN, Margaret
    13 Langley Close
    Magor
    NP26 3HW Caldicot
    Gwent
    Secrétaire
    13 Langley Close
    Magor
    NP26 3HW Caldicot
    Gwent
    British65638610001
    HIGHSTONE SECRETARIES LIMITED
    Highstone House
    165 High Street
    EN5 5SU Barnet
    Hertfordshire
    Secrétaire désigné
    Highstone House
    165 High Street
    EN5 5SU Barnet
    Hertfordshire
    900014180001
    LYNCH, Sally
    2 Blenheim Avenue
    Magor
    NP26 3NB Newport
    Administrateur
    2 Blenheim Avenue
    Magor
    NP26 3NB Newport
    BritishCommunity Care90301570001
    WHITE, Ian James
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Bradbury House 830
    Essex
    Administrateur
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Bradbury House 830
    Essex
    EnglandBritishAccountant133383410003
    HIGHSTONE DIRECTORS LIMITED
    Highstone House
    165 High Street
    EN5 5SU Barnet
    Hertfordshire
    Administrateur désigné
    Highstone House
    165 High Street
    EN5 5SU Barnet
    Hertfordshire
    900014170001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SALLY LYNCH COMMUNITY CARE ENTERPRISES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Paul Anthony Keith Jeffery
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Bradbury House 830
    Essex
    06 avr. 2016
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Bradbury House 830
    Essex
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.
    Consensus Support Services
    830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Bradbury House
    England
    06 avr. 2016
    830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Bradbury House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement4081379
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SALLY LYNCH COMMUNITY CARE ENTERPRISES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 11 sept. 2013
    Livré le 19 sept. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 19 sept. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 avr. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 11 sept. 2013
    Livré le 17 sept. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Griffin-American Healthcare Reit Ii, Inc
    Transactions
    • 17 sept. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 avr. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 11 sept. 2013
    Livré le 16 sept. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ga Hc Reit Ii Ch UK Senior Housing Portfolio LTD
    Transactions
    • 16 sept. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 avr. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 28 juil. 2010
    Livré le 06 août 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 06 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 30 mars 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession and charge
    Créé le 20 juin 2008
    Livré le 23 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Finance Parties
    Transactions
    • 23 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 15 juin 2005
    Livré le 22 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 juil. 2004
    Livré le 14 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land lying to the south of ffwrwm road machen caerphilly and the dwellinghouse erected thereon. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 14 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 févr. 2004
    Livré le 17 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property known as pool head cottage and land adjoining wilcrick magor caldicot NP26 3DA. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 17 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 févr. 2004
    Livré le 17 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that l/h property known as ashbury house west end magor caldicot monmouthshire NP26 3HT. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 17 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 févr. 2004
    Livré le 17 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 17 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0