STAMS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | STAMS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04783263 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe STAMS LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Interpath Limited 10 Fleet Place EC4M 7RB London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de STAMS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour STAMS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 17 pages | LIQ13 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Claude Kwasi Sarfo-Agyare en tant que directeur le 20 déc. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 4 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Emerald Buildings Westmere Drive Crewe Cheshire CW1 6UN United Kingdom à C/O Interpath Limited 10 Fleet Place London EC4M 7RB le 04 oct. 2022 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 19 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 17 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Claude Kwasi Sarfo-Agyare le 07 sept. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Claude Kwasi Sarfo-Agyare en tant qu'administrateur le 04 nov. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew James Morris en tant que directeur le 04 nov. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 juin 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew James Morris le 04 janv. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 20 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Patrick Clancy en tant que directeur le 31 juil. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 juin 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Lifestyle Services Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 mai 2018 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Emerald Buildings Westmere Drive Crewe Cheshire CW1 6UN | 1 pages | AD04 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 6-12 Victoria Street Windsor Berkshire SL4 1EN à Emerald Buildings Westmere Drive Crewe Cheshire CW1 6UN le 29 mai 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Darren John Billings en tant que directeur le 07 déc. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de STAMS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADDOCK, Natalie Ann | Secrétaire | Westmere Drive CW1 6UN Crewe Emerald Buildings Cheshire United Kingdom | 192663430001 | |||||||
| BUTLER, John Michael | Secrétaire | 27 Headingley Mews St John's WF1 3AB Wakefield West Yorkshire | British | 87985410004 | ||||||
| GRAVES, John Osborne | Secrétaire | Little Paddock 3 White Beam Way KT20 5DL Tadworth Surrey | English | 51918630002 | ||||||
| GRAVILLE, Christian | Secrétaire | Victoria Street SL4 1EN Windsor 6-12 Berkshire United Kingdom | British | 182767970001 | ||||||
| LLOYD, Steven | Secrétaire | Victoria Street SL4 1EN Windsor 6-12 Berkshire | British | 133212170002 | ||||||
| BALSLEY, William Michael | Administrateur | Victoria Street SL4 1EN Windsor 6-12 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | American | 161064690001 | |||||
| BILLINGS, Darren John | Administrateur | Westmere Drive CW1 6UN Crewe Emerald Buildings Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 103631680002 | |||||
| BLACK, Ian Spencer | Administrateur | 402 Birkby Road HD2 2DN Huddersfield West Yorkshire | England | British | 50474580001 | |||||
| BLUNDELL, John Giles | Administrateur | 1 Littlewick Place Littlewick Green SL6 3RA Maidenhead Berkshire | England | British | 40752730002 | |||||
| CLANCY, Timothy Patrick | Administrateur | Westmere Drive CW1 6UN Crewe Emerald Buildings Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 250013690001 | |||||
| DEVEY, Robert Alan | Administrateur | 16 Langcliffe Avenue HG2 8JQ Harrogate North Yorkshire | Uk | British | 101508990001 | |||||
| DOBSON, Philip David | Administrateur | Victoria Street SL4 1EN Windsor 6-12 Berkshire | United Kingdom | British | 95437530004 | |||||
| KIRKWOOD, Alan Ford | Administrateur | 5 Craiglockhart Loan EH14 1HU Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 116266980001 | |||||
| MORRIS, Andrew James | Administrateur | Westmere Drive CW1 6UN Crewe Emerald Buildings Cheshire United Kingdom | England | British | 188465670001 | |||||
| MORRIS, John Edward | Administrateur | Victoria Street SL4 1EN Windsor 6-12 Berkshire | England | British | 92903390003 | |||||
| POSNER, Howard Michael | Administrateur | Stocks Lane HX2 6PR Luddenden Eaves House Halifax | United Kingdom | British | 139631580001 | |||||
| PRINGLE, Martin John | Administrateur | Victoria Street SL4 1EN Windsor 6-12 Berkshire United Kingdom | Scotland | British | 278248950001 | |||||
| SARFO-AGYARE, Claude Kwasi | Administrateur | Westmere Drive CW1 6UN Crewe Emerald Buildings Cheshire United Kingdom | England | British | 170061790002 | |||||
| VIALOU CLARK, Henry Max | Administrateur | 66 Cornwall Road HG1 2NE Harrogate North Yorkshire | British | 108160470001 | ||||||
| WARREN, Michael Ian | Administrateur | 137 Oakenshaw Lane Walton WF2 6NL Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | 94336310002 | |||||
| WHITEHAIR, Colin Roy Keith | Administrateur | Ore Close Lymedale Business Park ST5 9QD Newcastle Under Lyme Osprey House Staffordshire | England | British | 3042720002 | |||||
| WHITING, Timothy James | Administrateur | Victoria Street SL4 1EN Windsor 6-12 Berkshire | United Kingdom | British | 44028500003 | |||||
| WOOLGROVE, Thomas | Administrateur | Northwold Woodacre Crescent Bardsey LS17 9DQ Leeds West Yorkshire | British | 103184580001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STAMS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifestyle Services Group Limited | 06 avr. 2016 | Westmere Drive CW1 6UN Crewe Emerald Buildings Cheshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
STAMS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 15 mai 2013 Livré le 24 mai 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| An omnibus set-off agreement | Créé le 22 déc. 2011 Livré le 23 déc. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the companies with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in any other currency or currency unit, and the debt or debts owing by the bank represented by any such sum or sums (each such sum and debt being a credit balance). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 03 mai 2011 Livré le 16 mai 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any member of the group to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of admission to an omnibus letter of set-off | Créé le 12 févr. 2010 Livré le 16 févr. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Consent letter | Créé le 08 déc. 2009 Livré le 18 déc. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The short particulars of all the property mortgaged or charged are as set out in the debenture, in the consent letter the company charges, all investments, including any dividend, see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Omnibus letter of set-off (oslo) | Créé le 24 sept. 2009 Livré le 01 oct. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A deed of accession | Créé le 29 juin 2009 Livré le 07 juil. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
STAMS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0