STAMS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTAMS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04783263
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STAMS LIMITED ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe STAMS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Interpath Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STAMS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ST ANDREW'S MEMBERSHIP SERVICES LTD02 juin 200302 juin 2003

    Quels sont les derniers comptes de STAMS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour STAMS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    17 pagesLIQ13

    Cessation de la nomination de Claude Kwasi Sarfo-Agyare en tant que directeur le 20 déc. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 20 sept. 2022

    LRESSP

    Changement d'adresse du siège social de Emerald Buildings Westmere Drive Crewe Cheshire CW1 6UN United Kingdom à C/O Interpath Limited 10 Fleet Place London EC4M 7RB le 04 oct. 2022

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Déclaration de confirmation établie le 02 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    19 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 02 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    17 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Claude Kwasi Sarfo-Agyare le 07 sept. 2020

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 02 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Claude Kwasi Sarfo-Agyare en tant qu'administrateur le 04 nov. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew James Morris en tant que directeur le 04 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 02 juin 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew James Morris le 04 janv. 2019

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    20 pagesAA

    Cessation de la nomination de Timothy Patrick Clancy en tant que directeur le 31 juil. 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 02 juin 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des détails de Lifestyle Services Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 mai 2018

    2 pagesPSC05

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Emerald Buildings Westmere Drive Crewe Cheshire CW1 6UN

    1 pagesAD04

    Changement d'adresse du siège social de 6-12 Victoria Street Windsor Berkshire SL4 1EN à Emerald Buildings Westmere Drive Crewe Cheshire CW1 6UN le 29 mai 2018

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Darren John Billings en tant que directeur le 07 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de STAMS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PADDOCK, Natalie Ann
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    192663430001
    BUTLER, John Michael
    27 Headingley Mews
    St John's
    WF1 3AB Wakefield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    27 Headingley Mews
    St John's
    WF1 3AB Wakefield
    West Yorkshire
    British87985410004
    GRAVES, John Osborne
    Little Paddock
    3 White Beam Way
    KT20 5DL Tadworth
    Surrey
    Secrétaire
    Little Paddock
    3 White Beam Way
    KT20 5DL Tadworth
    Surrey
    English51918630002
    GRAVILLE, Christian
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    United Kingdom
    British182767970001
    LLOYD, Steven
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    Secrétaire
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    British133212170002
    BALSLEY, William Michael
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomAmerican161064690001
    BILLINGS, Darren John
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish103631680002
    BLACK, Ian Spencer
    402 Birkby Road
    HD2 2DN Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    402 Birkby Road
    HD2 2DN Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish50474580001
    BLUNDELL, John Giles
    1 Littlewick Place
    Littlewick Green
    SL6 3RA Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    1 Littlewick Place
    Littlewick Green
    SL6 3RA Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish40752730002
    CLANCY, Timothy Patrick
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish250013690001
    DEVEY, Robert Alan
    16 Langcliffe Avenue
    HG2 8JQ Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    16 Langcliffe Avenue
    HG2 8JQ Harrogate
    North Yorkshire
    UkBritish101508990001
    DOBSON, Philip David
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    Administrateur
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    United KingdomBritish95437530004
    KIRKWOOD, Alan Ford
    5 Craiglockhart Loan
    EH14 1HU Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    5 Craiglockhart Loan
    EH14 1HU Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish116266980001
    MORRIS, Andrew James
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish188465670001
    MORRIS, John Edward
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    Administrateur
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    EnglandBritish92903390003
    POSNER, Howard Michael
    Stocks Lane
    HX2 6PR Luddenden
    Eaves House
    Halifax
    Administrateur
    Stocks Lane
    HX2 6PR Luddenden
    Eaves House
    Halifax
    United KingdomBritish139631580001
    PRINGLE, Martin John
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish278248950001
    SARFO-AGYARE, Claude Kwasi
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170061790002
    VIALOU CLARK, Henry Max
    66 Cornwall Road
    HG1 2NE Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    66 Cornwall Road
    HG1 2NE Harrogate
    North Yorkshire
    British108160470001
    WARREN, Michael Ian
    137 Oakenshaw Lane
    Walton
    WF2 6NL Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    137 Oakenshaw Lane
    Walton
    WF2 6NL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish94336310002
    WHITEHAIR, Colin Roy Keith
    Ore Close
    Lymedale Business Park
    ST5 9QD Newcastle Under Lyme
    Osprey House
    Staffordshire
    Administrateur
    Ore Close
    Lymedale Business Park
    ST5 9QD Newcastle Under Lyme
    Osprey House
    Staffordshire
    EnglandBritish3042720002
    WHITING, Timothy James
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    Administrateur
    Victoria Street
    SL4 1EN Windsor
    6-12
    Berkshire
    United KingdomBritish44028500003
    WOOLGROVE, Thomas
    Northwold
    Woodacre Crescent Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Northwold
    Woodacre Crescent Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    British103184580001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STAMS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Westmere Drive
    CW1 6UN Crewe
    Emerald Buildings
    Cheshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05114385
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    STAMS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 15 mai 2013
    Livré le 24 mai 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 24 mai 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    An omnibus set-off agreement
    Créé le 22 déc. 2011
    Livré le 23 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the companies with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in any other currency or currency unit, and the debt or debts owing by the bank represented by any such sum or sums (each such sum and debt being a credit balance).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 23 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 03 mai 2011
    Livré le 16 mai 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any member of the group to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V.London Branch (As Security Trustee)
    Transactions
    • 16 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off
    Créé le 12 févr. 2010
    Livré le 16 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 24 avr. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Consent letter
    Créé le 08 déc. 2009
    Livré le 18 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The short particulars of all the property mortgaged or charged are as set out in the debenture, in the consent letter the company charges, all investments, including any dividend, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V. London Branch
    Transactions
    • 18 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 24 avr. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Omnibus letter of set-off (oslo)
    Créé le 24 sept. 2009
    Livré le 01 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 avr. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    A deed of accession
    Créé le 29 juin 2009
    Livré le 07 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V, London Branch (The Security Trustee)
    Transactions
    • 07 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 avr. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    STAMS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 sept. 2022Commencement of winding up
    15 août 2023Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David John Pike
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Nicholas James Timpson
    Interpath Limited 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    Interpath Limited 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0