BENCH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBENCH LIMITED
    Statut de la sociétéEn administration
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04787106
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BENCH LIMITED ?

    • Commerce de gros de vêtements et de chaussures (46420) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Vente au détail de vêtements en magasin spécialisé (47710) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe BENCH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BENCH LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AMERICANA INTERNATIONAL LIMITED21 août 200321 août 2003
    INHOCO 2853 LIMITED04 août 200304 août 2003
    AMERICANA INTERNATIONAL (2003) LIMITED28 juil. 200328 juil. 2003
    INHOCO 2853 LIMITED04 juin 200304 juin 2003

    Quels sont les derniers comptes de BENCH LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 juin 2017
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2018
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au25 juin 2016

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BENCH LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au19 avr. 2019
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation03 mai 2019
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au19 avr. 2018
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour BENCH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    28 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    27 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    24 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    25 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    22 pagesAM10

    Avis de l'ordonnance de révocation de l'administrateur de ses fonctions

    13 pagesAM16

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    23 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    4 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    22 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    28 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    29 pagesAM10

    Changement d'adresse du siège social de 3 Hardman Street Spinningfields Manchester M3 3AT à C/O Bdo Llp 5 Temple Square Temple Street Liverpool L2 5RH le 28 oct. 2021

    2 pagesAD01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    34 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    4 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    30 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    30 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    30 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    40 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    30 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    6 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    28 pagesAM10

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    14 pagesAM02

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    11 pagesAM02

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    11 pagesAM02

    Qui sont les dirigeants de BENCH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement7038430
    146358090001
    KNIGHT, Barry Scott
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    Administrateur
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    United KingdomBritish224292410001
    COOPER, Anna Marie
    54 Parsonage Road
    Withington
    M20 4WQ Manchester
    Greater Manchester
    Secrétaire
    54 Parsonage Road
    Withington
    M20 4WQ Manchester
    Greater Manchester
    British91115720001
    DONALDSON, Steven
    Park House
    1a Park Drive
    WA15 9DW Hale
    Cheshire
    Secrétaire
    Park House
    1a Park Drive
    WA15 9DW Hale
    Cheshire
    British59569960002
    MORGAN, Margaret Frances
    8 Hawkshaw Close
    Hawkshaw
    BL8 4GZ Bury
    Secrétaire
    8 Hawkshaw Close
    Hawkshaw
    BL8 4GZ Bury
    Irish112262740001
    STOUT, Paul
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    Secrétaire
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    British140663950001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BAIRD, Gordon Martin
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United Kingdom
    Administrateur
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United Kingdom
    United KingdomBritish161091990001
    BROCK, David Michael
    Windyridge
    44 Beechwood Avenue
    HP6 6PN Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Windyridge
    44 Beechwood Avenue
    HP6 6PN Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish22121020001
    COOPER, Anna Marie
    54 Parsonage Road
    Withington
    M20 4WQ Manchester
    Greater Manchester
    Administrateur
    54 Parsonage Road
    Withington
    M20 4WQ Manchester
    Greater Manchester
    British91115720001
    DONALDSON, Steven
    Park House
    1a Park Drive
    WA15 9DW Hale
    Cheshire
    Administrateur
    Park House
    1a Park Drive
    WA15 9DW Hale
    Cheshire
    British59569960002
    HAGUE, Simon David
    Horsted Lane
    Sharpthorne
    RH19 4HX East Grinsted
    Kixes Farm
    Administrateur
    Horsted Lane
    Sharpthorne
    RH19 4HX East Grinsted
    Kixes Farm
    Great BritainBritish142147510001
    HORRIDGE, Alan
    49 Daniels Lane
    WN8 9NH Skelmersdale
    Lancashire
    Administrateur
    49 Daniels Lane
    WN8 9NH Skelmersdale
    Lancashire
    British74178900001
    MASTERS, Paul Raymond
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    Administrateur
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United KingdomBritish135638050003
    MCGUIGAN, Peter
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    Administrateur
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    EnglandBritish136211350001
    MORGAN, Margaret Frances
    8 Hawkshaw Close
    Hawkshaw
    BL8 4GZ Bury
    Administrateur
    8 Hawkshaw Close
    Hawkshaw
    BL8 4GZ Bury
    United KingdomIrish112262740001
    PEACOCK, Gregory Garth
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United Kingdom
    Administrateur
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United Kingdom
    GermanyBritish211457970001
    SAELZER, Bruno, Dr
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United Kingdom
    Administrateur
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United Kingdom
    GermanyGerman195373380001
    STOUT, Paul
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    Administrateur
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United KingdomBritish140663950001
    TURNER, Mark Robert James
    The Rookery
    Bishopstone
    HP17 8SH Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Rookery
    Bishopstone
    HP17 8SH Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish101563880001
    VIDLER, Kelvin Bryan
    3 Churchfields
    Wybunbury
    CW5 7LL Nantwich
    Cheshire
    Administrateur
    3 Churchfields
    Wybunbury
    CW5 7LL Nantwich
    Cheshire
    British101430940001
    WOELFLE, Thomas, Dr
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United Kingdom
    Administrateur
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United Kingdom
    GermanyGerman203963520001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Administrateur désigné
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour BENCH LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    05 avr. 2017La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société.

    BENCH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 05 févr. 2016
    Livré le 08 févr. 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 08 févr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 27 avr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 mai 2014
    Livré le 02 mai 2014
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Beechbrook Mezzanine Ii Jersey Limited as Security Agent
    Transactions
    • 02 mai 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 01 mai 2014
    Livré le 01 mai 2014
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 01 mai 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 29 avr. 2014
    Livré le 02 mai 2014
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Beechbrook Mezzanine Ii Jersey Limited
    Transactions
    • 02 mai 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 29 avr. 2014
    Livré le 02 mai 2014
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Beechbrook Mezzanine Ii Jersey Limited
    Transactions
    • 02 mai 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 29 avr. 2014
    Livré le 02 mai 2014
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C
    Transactions
    • 02 mai 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 29 avr. 2014
    Livré le 02 mai 2014
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C
    Transactions
    • 02 mai 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    Rent deposit deed
    Créé le 29 avr. 2010
    Livré le 06 mai 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £18,829.39 or such other monies and interest.
    Personnes ayant droit
    • Freeport (Nominee 1) Limited and Freeport (Nominee 2) Limited
    Transactions
    • 06 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit deed
    Créé le 09 juil. 2009
    Livré le 17 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the depopsit monies see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lasalle UK Ventures Property 11 S.A.R.L.
    Transactions
    • 17 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Senior german share pledge
    Créé le 30 mars 2007
    Livré le 17 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the borrowers and any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The pledgor pledges the registered fully paid up share capital being the one share in the company held by the pledgor with a nominal value of eur 50,000 all future and/or increased shares as well as rights for subscription of new shares all current and future rights and claims associated with the pledgors shares including dividends liquidation proceeds redemption proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Australia Bank Limited
    Transactions
    • 17 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mezzanine german share pledge
    Créé le 30 mars 2007
    Livré le 17 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and by the mezzanine borrower and any other mezzanine obligor and each grantor to the chargee on any account whatsover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The pledgor pledges the registered fully paid up share capital being the one share in the company held by the pledgor with a nominal value of eur 50,000 all future and/or increased shares as well as rights for subscription of new shares all current and future rights and claims associated with the pledgors shares including dividends liquidation proceeds redemption proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Australia Bank Limited
    Transactions
    • 17 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 29 mars 2007
    Livré le 11 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Australia Bank Limited Abn 12 004 044 937 (The Security Trustee)
    Transactions
    • 11 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 28 mars 2007
    Livré le 13 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the investors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hg Pooled Management Limited (As Investor Security Trustee for the Investor Finance Parties)
    Transactions
    • 13 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge agreement executed outside the united kingdom and comprising property situated there
    Créé le 25 nov. 2005
    Livré le 20 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee and/or any other secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The exising shares and all additional shares in the capital of the company (americana germany gmbh) in whatever nominal value which the pledgor may aquire in the future in the event of a share transfer, an increase of the capital of the company or otherwise together with all ancillary rights and claims associated with the shares reffered to under clause 5 to the share pledge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Australia Bank Limited ("the Pledgee")
    Transactions
    • 20 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment by way of security
    Créé le 01 nov. 2005
    Livré le 08 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by each of the obligors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Each policy and all policy proceeds and all its right title and interest present and future in each policy. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Australia Bank Limited in Its Capacity as Trustee and Security Agent for the Secured Parties
    Transactions
    • 08 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 01 nov. 2005
    Livré le 08 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by each of the obligors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Australia Bank Limited in Its Capacity as Trustee and Security Agent for the Secured Parties
    Transactions
    • 08 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 01 mars 2004
    Livré le 05 mars 2004
    En cours
    Montant garanti
    £88,125 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The deposit of £88,125 is charged to the landlord under the rent deposit deed;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Equitable Life Assurance Society
    Transactions
    • 05 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Charge of deposit with the bank
    Créé le 07 août 2003
    Livré le 13 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account designation national westminster bank PLC re: simon hague loan notes account account number 70515875 sort code 51-61-11 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of an insurance policy
    Créé le 07 août 2003
    Livré le 13 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company has covenented to discharge all of the companys obligations and as a continuing security for such discharge and with full such discharge and with full title guarantee assigned to the bank the policy over the life of alan horridge with lutine assurance services limited (policy number 211374) and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment on redemption. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of an insurance policy
    Créé le 07 août 2003
    Livré le 13 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company has covenanted to discharge all of the companys obligations and as a continuing security for such discharge and with full title guarantee assigned to the bank the policy over the life of jonathan stuart white with lutine assurance services limited (policy number 211375) and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment on redemption. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of an insurance policy
    Créé le 07 août 2003
    Livré le 13 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company has covenanted to discharge all of the companys obligations and as a continuing security for such discharge and with full title guarantee assigned to the bank the policy over the life of margaret frances morgan with lutine assurance services limited (policy number 211376) and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment on redemption. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of an insurance policy
    Créé le 07 août 2003
    Livré le 13 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company has covenanted to discharge all of the companys obligations and as a continuing security for such discharge and with full title guarantee assigned to the bank the policy over the life of anna marie cooper with lutine assurance services limited (policy number 211386) and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment or redemption. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of an insurance policy
    Créé le 07 août 2003
    Livré le 13 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company has covenanted to discharge all of the companys obligations and as a continuing security for such discharge and with full title guarantee assigned to the bank the policy over the life of simon david hague with lutine assurance services limited (policy number 211378) and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment on redemption. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 07 août 2003
    Livré le 13 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Isis Equity Partners PLC (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 13 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 août 2003
    Livré le 13 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BENCH LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 mai 2018Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Kerry Bailey
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    practitioner
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Martha Hanora Thompson
    Bdo Llp
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Antony David Nygate
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0