SJS REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSJS REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04788370
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SJS REALISATIONS LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe SJS REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Woodard Corporation High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SJS REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ST JAMES' SCHOOL,GRIMSBY LTD05 juin 200305 juin 2003

    Quels sont les derniers comptes de SJS REALISATIONS LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 août 2024
    Date d'échéance des prochains comptes31 mai 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SJS REALISATIONS LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au05 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation19 juin 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au05 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour SJS REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Jane Margaret Bowman en tant que directeur le 23 janv. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Sanderson en tant que directeur le 23 janv. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Bozena Ludmila Katarzyna Allen en tant que directeur le 23 janv. 2025

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 05 juin 2024 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Miles Stuart Hedges en tant qu'administrateur le 04 avr. 2024

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 août 2023

    26 pagesAA

    Nomination de The Woodard Corporation Limited en tant qu'administrateur le 04 avr. 2024

    2 pagesAP02

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Statuts

    20 pagesMA

    Déclaration de confirmation établie le 05 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 août 2022

    32 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 août 2021

    40 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Major en tant que secrétaire le 04 févr. 2022

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de 22 Bargate Grimsby North East Lincolnshire DN34 4SY à Woodard Corporation High Street Abbots Bromley Rugeley WS15 3BW le 20 oct. 2021

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 août 2020

    39 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 047883700010 en totalité

    1 pagesMR04

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name12 mai 2021

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Qui sont les dirigeants de SJS REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HEDGES, Miles Stuart
    High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    Woodard Corporation
    England
    Administrateur
    High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    Woodard Corporation
    England
    EnglandBritishChartered Accountant323777280001
    THE WOODARD CORPORATION LIMITED
    High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    Woodard Schools
    England
    Administrateur
    High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    Woodard Schools
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement04659710
    321704870001
    BEESLEY, Peter Frederick Barton
    25 Rotherwick Road
    NW11 7DG London
    Secrétaire
    25 Rotherwick Road
    NW11 7DG London
    British5308180001
    HEWINS, Paul Henry
    Ingham House
    Chapel Lane
    LN7 6DE Swallow
    Lincolnshire
    Secrétaire
    Ingham House
    Chapel Lane
    LN7 6DE Swallow
    Lincolnshire
    BritishSchool Bursar31331280002
    ISAAC, Susan Mary
    Aspen House
    34 The Drive Waltham
    DN37 OFB Grimsby
    N E Lincolnshire
    Secrétaire
    Aspen House
    34 The Drive Waltham
    DN37 OFB Grimsby
    N E Lincolnshire
    BritishHead Teacher112119280001
    MAJOR, Andrew
    Keddington Road
    LN11 0AU Louth
    64
    Lincolnshire
    England
    Secrétaire
    Keddington Road
    LN11 0AU Louth
    64
    Lincolnshire
    England
    154138070001
    ADAMS, John Gilbert
    31 Welholme Avenue
    DN32 0DZ Grimsby
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    31 Welholme Avenue
    DN32 0DZ Grimsby
    North East Lincolnshire
    United KingdomBritishRetired10925580001
    ALLEN, Bozena Ludmila Katarzyna
    Somerby Green
    Somerby
    DN38 6EY Barnetby
    Domma
    England
    Administrateur
    Somerby Green
    Somerby
    DN38 6EY Barnetby
    Domma
    England
    EnglandBritishBusiness Consultant81941160001
    BARFORD, Peter Mark
    The Oaks
    Main Road, Barnoldby -Le-Beck
    DN37 0AU Grimsby
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    The Oaks
    Main Road, Barnoldby -Le-Beck
    DN37 0AU Grimsby
    North East Lincolnshire
    United KingdomBritishCompany Director34719940002
    BASS, Judith Mary
    1 Church Lane
    North Ormsby
    LN11 0TJ Louth
    Dragonfly
    Lincolnshire
    England
    Administrateur
    1 Church Lane
    North Ormsby
    LN11 0TJ Louth
    Dragonfly
    Lincolnshire
    England
    EnglandBritishRetired205133100001
    BAXTER, Alexander Easton
    Sophia Avenue
    Scartho
    DN33 3NH Grimsby
    18
    South Humberside
    England
    Administrateur
    Sophia Avenue
    Scartho
    DN33 3NH Grimsby
    18
    South Humberside
    England
    EnglandBritishManaging Director97803860001
    BEESLEY, Peter Frederick Barton
    25 Rotherwick Road
    NW11 7DG London
    Administrateur
    25 Rotherwick Road
    NW11 7DG London
    EnglandBritishSolicitor5308180001
    BOWMAN, Jane Margaret
    Post Office Lane
    Ashby-Cum-Fenby
    DN37 0QS Grimsby
    Little Fenby
    England
    Administrateur
    Post Office Lane
    Ashby-Cum-Fenby
    DN37 0QS Grimsby
    Little Fenby
    England
    EnglandBritishRetired Heasteacher267810410001
    BRANT, Margaret Watt
    Normanby Holt
    Normanby Le Wold
    LN8 3YZ Market Rasen
    Lincolnshire
    Administrateur
    Normanby Holt
    Normanby Le Wold
    LN8 3YZ Market Rasen
    Lincolnshire
    BritishNone91854670001
    BROWN, Rodney Lynwode
    St Mary's House
    Covenham St Mary
    LN11 0PG Louth
    Lincolnshire
    Administrateur
    St Mary's House
    Covenham St Mary
    LN11 0PG Louth
    Lincolnshire
    United KingdomBritishCompany Director17461620001
    BURY, David Frederick
    4 Park Drive
    DN32 0EE Grimsby
    Fairlawns
    South Humberside
    England
    Administrateur
    4 Park Drive
    DN32 0EE Grimsby
    Fairlawns
    South Humberside
    England
    United KingdomBritishCompany Director8195000002
    CARROLL, David Patrick
    13 Augusta Close
    DN34 4TG Grimsby
    End House
    South Humberside
    Administrateur
    13 Augusta Close
    DN34 4TG Grimsby
    End House
    South Humberside
    EnglandBritishManaging Director108234100003
    CLOVER, Brendan David, The Reverend Canon
    45 Lower Burlington Road
    BS20 7BP Portishead
    North Somerset
    Administrateur
    45 Lower Burlington Road
    BS20 7BP Portishead
    North Somerset
    United KingdomBritishSenior Provost117789460001
    DELLAR, Howard John
    14 Silver Road
    OX4 3AP Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    14 Silver Road
    OX4 3AP Oxford
    Oxfordshire
    BritishSolicitor86979020001
    DOUGLAS, Roger James
    The Old Rectory
    Croxby
    LN7 6BW Market Rasen
    Lincolnshire
    Administrateur
    The Old Rectory
    Croxby
    LN7 6BW Market Rasen
    Lincolnshire
    EnglandBritishFarmer98395240001
    DYSON, Jacqueline Diana
    The Willows 9 Aylesby Lane
    Healing
    DN41 7QP Grimsby
    South Humberside
    Administrateur
    The Willows 9 Aylesby Lane
    Healing
    DN41 7QP Grimsby
    South Humberside
    United KingdomBritishAdministration Clerical47368030001
    ENGLAND, Robert Donald
    George Butler Close
    Laceby
    DN37 7WA Grimsby
    5
    South Humberside
    England
    Administrateur
    George Butler Close
    Laceby
    DN37 7WA Grimsby
    5
    South Humberside
    England
    EnglandBritishAccountant114528770001
    FURNEAUX, Tom
    Bargate
    DN34 4SY Grimsby
    22
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    Bargate
    DN34 4SY Grimsby
    22
    North East Lincolnshire
    EnglandBritishSolicitor255797810001
    HAITH, Rachael Lea
    Deighton Close
    LN11 0RR Louth
    Deighton Close Hall
    Lincolnshire
    England
    Administrateur
    Deighton Close
    LN11 0RR Louth
    Deighton Close Hall
    Lincolnshire
    England
    EnglandBritishCompany Director151724920001
    HAITH, Rachael Lea
    Bradley Manor
    Church Lane Bradley
    DN37 0BQ Grimsby
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    Bradley Manor
    Church Lane Bradley
    DN37 0BQ Grimsby
    North East Lincolnshire
    BritishCompany Secretary98395350001
    HANNINGTON, Barry George
    The Old Rectory
    Gainsby
    DN36 5PT Grimbsby
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    The Old Rectory
    Gainsby
    DN36 5PT Grimbsby
    North East Lincolnshire
    EnglandBritishRetired50886760003
    HARVEY, Steven Charles, The Revd
    The Provost's Lodging
    High Street Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    Staffordshire
    Administrateur
    The Provost's Lodging
    High Street Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    Staffordshire
    BritishSenior Provost95286410001
    JAMES, David Wynne, Dr
    Orford House
    Orford
    LN8 6HW Market Rasen
    Lincolnshire
    Administrateur
    Orford House
    Orford
    LN8 6HW Market Rasen
    Lincolnshire
    BritishPhysician91854230001
    LOCKWOOD, James
    Welholme Road
    DN32 0ND Grimsby
    56
    North East Lincolnshire
    England
    Administrateur
    Welholme Road
    DN32 0ND Grimsby
    56
    North East Lincolnshire
    England
    EnglandBritishArchitect194660440001
    LYNCH, Paul Newman
    Asgard Way
    Scartho Top
    DN33 3RJ Grimsby
    20
    South Humberside
    Administrateur
    Asgard Way
    Scartho Top
    DN33 3RJ Grimsby
    20
    South Humberside
    EnglandBritishRaw Materials And Stock Coordinator138958910001
    O'LEARY, Liam Jack
    Richmond Road
    DN35 8PQ Cleethorpes
    47
    England
    Administrateur
    Richmond Road
    DN35 8PQ Cleethorpes
    47
    England
    EnglandBritishCompany Director131949340002
    OVERTON, David Vernon
    49 Welholme Avenue
    DN32 0DZ Grimsby
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    49 Welholme Avenue
    DN32 0DZ Grimsby
    North East Lincolnshire
    United KingdomBritishSolicitor49460960001
    PALMER, David Charles
    Devonshire Avenue
    DN32 0BW Grimsby
    24
    South Humberside
    England
    Administrateur
    Devonshire Avenue
    DN32 0BW Grimsby
    24
    South Humberside
    England
    EnglandBritishSocial Worker198342490001
    PEMBERTON, John, Doctor
    4 Priestgate
    DN18 5ET Barton On Humber
    North Lincolnshire
    Administrateur
    4 Priestgate
    DN18 5ET Barton On Humber
    North Lincolnshire
    BritishG P Retired106320940001
    PRIDGEON, John
    Keddington Corner
    LN11 7DX Louth
    River Farm
    Lincolnshire
    England
    Administrateur
    Keddington Corner
    LN11 7DX Louth
    River Farm
    Lincolnshire
    England
    EnglandBritishFarmer202635140001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SJS REALISATIONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Woodard Corporation
    High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    Woodard School
    Staffordshire
    England
    06 avr. 2016
    High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    Woodard School
    Staffordshire
    England
    Non
    Forme juridiqueCompany Limited By Guarantee
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompany Limited By Guarantee
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement04659710
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une fiducie, et les fiduciaires de cette fiducie (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une fiducie, et les fiduciaires de cette fiducie (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    SJS REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 04 mars 2019
    Livré le 04 mars 2019
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Freehold property being st. James' school grimsby playing fields, bargate, grimsby registered at hm land registry with title number HS313309.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 04 mars 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 mai 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 13 nov. 2018
    Livré le 15 nov. 2018
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Freehold property being st. James' school grimsby playing fields, bargate, grimsby registered at hm land registry with title number HS313309.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 15 nov. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 mars 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 11 juin 2009
    Livré le 23 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The old rectory bargate grimsby north east lincolnshire t/no HS114982 and each and every part thereof and all buildings erections and structures and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and with the benefit of all existing and future leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants undertakings warranties floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixed charge all the benefit of and the right to enforce all contracts and agreements for the sale purchase leasing mortgaging management or other dealing with the mortgaged property all rents and licence fees floating charge the property assets and rights of the company.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 23 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mai 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 11 juin 2009
    Livré le 23 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    24 bargate grimsby north east lincolnshire t/no HS296891 and each and every part thereof and all buildings erections and structures and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and with the benefit of all existing and future leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants undertakings warranties floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixed charge all the benefit of and the right to enforce all contracts and agreements for the sale purchase leasing mortgaging management or other dealing with the mortgaged property all rents and licence fees floating charge the property assets and rights of the company.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 23 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mai 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 11 juin 2009
    Livré le 23 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    22 bargate grimsby north east lincolnshire t/no HS578382 and each and every part thereof and all buildings erections and structures and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and with the benefit of all existing and future leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants undertakings warranties floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixed charge all the benefit of and the right to enforce all contracts and agreements for the sale purchase leasing mortgaging management or other dealing with the mortgaged property all rents and licence fees floating charge the property assets and rights of the company.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 23 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mai 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 11 juin 2009
    Livré le 23 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    20 bargate grimsby north east lincolnshire t/no HS42414 and each and every part thereof and all buildings erections and structures and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and with the benefit of all existing and future leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants undertakings warranties floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixed charge all the benefit of and the right to enforce all contracts and agreements for the sale purchase leasing mortgaging management or other dealing with the mortgaged property all rents and licence fees floating charge the property assets and rights of the company.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 23 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mai 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 11 juin 2009
    Livré le 23 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    18 bargate grimsby north east lincolnshire t/no HS296889 and each and every part thereof and all buildings erections and structures and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and with the benefit of all existing and future leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants undertakings warranties floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixed charge all the benefit of and the right to enforce all contracts and agreements for the sale purchase leasing mortgaging management or other dealing with the mortgaged property all rents and licence fees floating charge the property assets and rights of the company.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 23 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mai 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 11 juin 2009
    Livré le 15 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 15 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mai 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 08 déc. 2003
    Livré le 11 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    18, 20, 22 & 24 bargate, grimsby, north east lincolnshire and land on the east side of bargate, grimsby, north east lincolnshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 sept. 2003
    Livré le 15 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The old rectory bargate grimsby north east lincolnshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0