INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED

INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04789693
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Cannon Place
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PRECIS (2361) LIMITED06 juin 200306 juin 2003

    Quels sont les derniers comptes de INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 28 juin 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 juin 2016

    État du capital au 20 juin 2016

    • Capital: GBP 5,004
    SH01

    Cessation de la nomination de Biif Corporate Services Limited en tant que directeur le 25 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr John Ivor Cavill en tant qu'administrateur le 04 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Nestor Augusto Castillo Borrero en tant que directeur le 04 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Biif Corporate Services Limited le 01 juil. 2015

    1 pagesCH02

    Changement d'adresse du siège social de C/O Dundas & Wilson North West Wing Bush House Aldwych London WC2B 4EZ à Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF le 01 juil. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 juin 2015

    État du capital au 17 juin 2015

    • Capital: GBP 5,004
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 juin 2014

    État du capital au 27 juin 2014

    • Capital: GBP 5,004
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nigel Wythen Middleton le 11 nov. 2013

    2 pagesCH01

    Nomination de Biif Corporate Services Limited en tant qu'administrateur

    2 pagesAP02

    Nomination de Mr Nestor Augusto Castillo Borrero en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Forrest en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Forrest le 21 mai 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Forrest le 11 nov. 2013

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement05372427
    128530180002
    CAVILL, John Ivor
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Administrateur
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    EnglandBritish152521640008
    MIDDLETON, Nigel Wythen
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Administrateur
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    United KingdomBritish156912990002
    LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICES LTD
    100 Wood Street
    EC2V 7EX London
    Fifth Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    100 Wood Street
    EC2V 7EX London
    Fifth Floor
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3388362
    90842510001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Stret
    EC2A 2HS London
    Secrétaire désigné
    Level 1 Exchange House
    Primrose Stret
    EC2A 2HS London
    900019420001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BELL, Andrew
    West Hill Park
    N6 6ND London
    39
    Administrateur
    West Hill Park
    N6 6ND London
    39
    EnglandBritish136926040003
    BUSBY, Colin Ronald William
    34 Duloe Road
    PE19 8FQ St Neots
    Cambridgeshire
    Administrateur
    34 Duloe Road
    PE19 8FQ St Neots
    Cambridgeshire
    EnglandBritish109817700001
    CASTILLO BORRERO, Nestor Augusto
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    3i
    United Kingdom
    Administrateur
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    3i
    United Kingdom
    EnglandBritish182601420001
    ELLIOTT, Christopher James
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish31541950004
    FORREST, Michael
    c/o Dundas & Wilson
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    North West Wing Bush House
    Administrateur
    c/o Dundas & Wilson
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    North West Wing Bush House
    United KingdomBritish169634490002
    HOGG, Cressida Mary
    W11
    Administrateur
    W11
    EnglandBritish85643820001
    JENNINGS, Oliver James Wake
    Barclays Bank
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    Barclays Bank
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish86815910002
    JONES, Nigel Stuart
    3 Osprey Court
    Star Place
    E1W 1AG London
    Administrateur
    3 Osprey Court
    Star Place
    E1W 1AG London
    British99472630001
    KING, Neil Edmund
    Annables Manor
    Annables Lane
    AL5 3PR Herpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    Annables Manor
    Annables Lane
    AL5 3PR Herpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish115057710001
    LEATHES, Simon William De Mussenden
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British9808160003
    MCCLATCHEY, Robert Sean
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    United KingdomBritish140441450001
    MONTAGUE, Adrian Alastair, Sir
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Administrateur
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    United KingdomBritish70647930007
    RYAN, Michael Joseph
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    Administrateur
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    United KingdomIrish77999320003
    SCOTT-BARRETT, Nicholas Huson
    Gatehouse Farm
    Crown Lane, Ardleigh
    CO7 7QZ Colchester
    Administrateur
    Gatehouse Farm
    Crown Lane, Ardleigh
    CO7 7QZ Colchester
    British59658050001
    VICKERSTAFF, Matthew
    2 Saint Andrews Avenue
    AL5 2RA Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Saint Andrews Avenue
    AL5 2RA Harpenden
    Hertfordshire
    British75379800001
    BIIF CORPORATE SERVICES LIMITED
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Administrateur
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement06793845
    188111290001
    PEREGRINE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Administrateur désigné
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    900019410001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement06704479
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 09 janv. 2009
    Livré le 19 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 19 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of confirmation
    Créé le 27 nov. 2008
    Livré le 06 déc. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares and all related rights see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 déc. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of confirmation
    Créé le 27 nov. 2008
    Livré le 06 déc. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares together with the related rights see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 déc. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of charge and assignment
    Créé le 29 janv. 2008
    Livré le 08 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from infrastructure investors limited (in its capacity as manager of the borrower under the deed) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of a first fixed charge its whole right title and interest in and to the shares together with the related rights, the investments. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge and assignment
    Créé le 20 déc. 2007
    Livré le 27 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares the related rights, the investments and the receivables,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 27 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed to deed of charge and assignment dated 21 december 2006
    Créé le 19 déc. 2007
    Livré le 28 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The right title and interest in and to the shares and investments. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC for Itself and as Agent and Security Trustee for the Other Finance Parties(The Security Trustee)
    Transactions
    • 28 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of charge and assignment
    Créé le 30 nov. 2007
    Livré le 11 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares together with the related rights; and the investments. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed to deed of charge and assignment dated 21 december 2006
    Créé le 09 nov. 2007
    Livré le 23 nov. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge its whole right,title and interest in and to the shares together with related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 23 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of charge and assignment
    Créé le 29 déc. 2006
    Livré le 06 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge all the shares together with the related rights,all the investments together with the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 06 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge and assignment
    Créé le 21 déc. 2006
    Livré le 05 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the shares in eastbrook facilities holdings 2 limited, normanby healthcare group holdings limited, anavon holdings limited with the related rights meaning all dividends, distributions and other income and all investments. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC for Itself and as Agent and Trustee for the Other Finance Parties (Thesecurity Trustee)
    Transactions
    • 05 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 24 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0