CB REALISATIONS (NO. 1) LIMITED

CB REALISATIONS (NO. 1) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCB REALISATIONS (NO. 1) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04791275
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CB REALISATIONS (NO. 1) LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe CB REALISATIONS (NO. 1) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    DELOITTE LLP
    5 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CB REALISATIONS (NO. 1) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CASHBOX ATM SYSTEMS LIMITED08 juin 200308 juin 2003

    Quels sont les derniers comptes de CB REALISATIONS (NO. 1) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour CB REALISATIONS (NO. 1) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 11 nov. 2011

    40 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 15 mai 2011

    33 pages2.24B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    9 pages2.16B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    44 pages2.17B

    Certificat de changement de nom

    Company name changed cashbox atm systems LIMITED\certificate issued on 22/12/10
    2 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Changement d'adresse du siège social de Windriver House Meridian Office Park Osborn Way Hook Hampshire RG27 9HY le 15 déc. 2010

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 juil. 2010

    État du capital au 30 juil. 2010

    • Capital: GBP 6,342
    SH01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 30 juin 2009

    23 pagesAA

    Nomination de Mr William Young Hughes en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 30 juin 2008

    26 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 juin 2007

    28 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 juin 2006

    29 pagesAA

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de CB REALISATIONS (NO. 1) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HUGHES, William Young
    Succoth Avenue
    EH12 6BE Edinburgh
    7
    United Kingdom
    Administrateur
    Succoth Avenue
    EH12 6BE Edinburgh
    7
    United Kingdom
    United KingdomBritish187980002
    MORTON, Ciaran Gregory
    13 Bishops Road
    N6 4HP London
    Administrateur
    13 Bishops Road
    N6 4HP London
    EnglandBritish121122960001
    THOMAS, Matthew John
    Avenue Lodge
    Avenue Road
    GU51 4NG Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    Avenue Lodge
    Avenue Road
    GU51 4NG Fleet
    Hampshire
    United KingdomBritish109045740001
    ARMES, Simon Philip Harcourt
    25 The Green
    Southwick
    BN42 4DG Brighton
    West Sussex
    Secrétaire
    25 The Green
    Southwick
    BN42 4DG Brighton
    West Sussex
    British48471250002
    AUGER, David
    52a Mornington Terrace
    NW1 7RT London
    Secrétaire
    52a Mornington Terrace
    NW1 7RT London
    British72608390001
    THOMAS, Catriona Marcia Mackenzie
    The Lanterns
    Reading Road
    RG27 8JZ Hound Green
    Hampshire
    Secrétaire
    The Lanterns
    Reading Road
    RG27 8JZ Hound Green
    Hampshire
    British92174060001
    WOOLSGROVE, Darren
    Willows End 3 Saint Normans Way
    KT17 1QW Ewell
    Surrey
    Secrétaire
    Willows End 3 Saint Normans Way
    KT17 1QW Ewell
    Surrey
    British122764860001
    AUGER, David
    52a Mornington Terrace
    NW1 7RT London
    Administrateur
    52a Mornington Terrace
    NW1 7RT London
    British72608390001
    BALL, Kristina
    Garstons Farm Cottage
    Chapel Road
    RH17 5NE Bolney
    West Sussex
    Administrateur
    Garstons Farm Cottage
    Chapel Road
    RH17 5NE Bolney
    West Sussex
    British85105350001
    HALLETT, Charles
    75c Perham Road
    W14 9SP London
    Administrateur
    75c Perham Road
    W14 9SP London
    British103409200002
    SHARP, Anthony Christopher John
    Penthouse Apartment
    Les Orangers, 42 Bis Boulevard Jardin Exotique
    Monaco Mc98000
    Monaco
    Administrateur
    Penthouse Apartment
    Les Orangers, 42 Bis Boulevard Jardin Exotique
    Monaco Mc98000
    Monaco
    British37199800009
    THOMAS, Carl John
    The Lanterns
    Reading Road,
    RG27 8JZ Hound Green
    Hampshire
    Administrateur
    The Lanterns
    Reading Road,
    RG27 8JZ Hound Green
    Hampshire
    British92173990001
    WILMOTT, Andrew Duncan
    52 Woodcote Road
    Caversham
    RG4 7BB Reading
    Berkshire
    Administrateur
    52 Woodcote Road
    Caversham
    RG4 7BB Reading
    Berkshire
    EnglandBritish120645550001
    WOOLSGROVE, Darren
    Willows End 3 Saint Normans Way
    KT17 1QW Ewell
    Surrey
    Administrateur
    Willows End 3 Saint Normans Way
    KT17 1QW Ewell
    Surrey
    United KingdomBritish122764860001

    CB REALISATIONS (NO. 1) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 29 juin 2007
    Livré le 05 juil. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 30 juin 2006
    Livré le 01 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • General Capital Venture Finance Limited
    Transactions
    • 01 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 10 août 2005
    Livré le 18 août 2005
    En cours
    Montant garanti
    £14,687.50 due or to become due from the company to
    Brèves mentions
    £14,687.50.
    Personnes ayant droit
    • Amprop Limited
    Transactions
    • 18 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 21 sept. 2004
    Livré le 29 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Tidel Engineering, L.P.
    Transactions
    • 29 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 07 sept. 2004
    Livré le 27 sept. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Its interest in the account into which the deposit is from time to time paid persuant to the deed and all monies standing to the credit of such account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cb Richard Ellis Collective Investors Limited (As Trustee for the Thames Water Pension Schemesproperty Fund)
    Transactions
    • 27 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)

    CB REALISATIONS (NO. 1) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 nov. 2010Administration started
    11 nov. 2011Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Michael Hawes
    5 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    practitioner
    5 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    Julia Elizabeth Branson
    Deloitte Llp
    Abbots House
    RG1 3BD Abbey Street
    Reading
    practitioner
    Deloitte Llp
    Abbots House
    RG1 3BD Abbey Street
    Reading

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0