COLERIDGE (NO.25) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | COLERIDGE (NO.25) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04796777 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe COLERIDGE (NO.25) LIMITED ?
| Adresse du siège social | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de COLERIDGE (NO.25) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour COLERIDGE (NO.25) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 43 pages | 4.71 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Neil Kenneth Robertson en tant que directeur le 24 févr. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU à The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG le 13 avr. 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015 | 3 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Claire Treacy en tant que directeur le 05 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Neil Kenneth Robertson en tant qu'administrateur le 05 janv. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Fraser James Kennedy en tant que directeur le 14 août 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Claire Treacy en tant qu'administrateur le 14 août 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 12 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 12 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013 | 3 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Valsec Director Limited le 01 juil. 2013 | 2 pages | CH02 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Fraser James Kennedy le 01 juil. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Europa House 20 Esplanade Scarborough YO11 2AQ* le 02 juil. 2013 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 12 juin 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2012 | 3 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de COLERIDGE (NO.25) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | 3 Semple Street EH3 8BL Edinburgh 1st Floor Exchange Place 3 United Kingdom |
| 133355520001 | ||||||||||
| VALSEC DIRECTOR LIMITED | Administrateur | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom |
| 102622300002 | ||||||||||
| RICHARDSON, Paul | Secrétaire | 2 Newdale Usher Park Haxby YO32 3LN York North Yorkshire | British | 60649820001 | ||||||||||
| DWS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | Five Chancery Lane Cliffords Inn EC4A 1BU London | 900023840001 | |||||||||||
| DI CIACCA, Cesidio Martin | Administrateur | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | Scotland | British | 1267050001 | |||||||||
| KENNEDY, Fraser James | Administrateur | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom | United Kingdom | British | 121610350003 | |||||||||
| MCBRIDE, Stephen Paul | Administrateur | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | United Kingdom | British | 56953000002 | |||||||||
| MCCABE, Kevin Charles | Administrateur | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | 109250000001 | ||||||||||
| OKUNOLA, Abayomi Abiodun | Administrateur | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | England | British | 135717740001 | |||||||||
| ROBERTSON, Neil Kenneth | Administrateur | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 158937210001 | |||||||||
| SHEPHERD, Marcus Owen | Administrateur | 64 Clarence Road TW11 0BW Teddington Middx | United Kingdom | British | 41925000003 | |||||||||
| TANDY, Didier Michel | Administrateur | 9 Warrington Crescent W9 1ED London | England | British | 69909950001 | |||||||||
| TREACY, Claire | Administrateur | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Irish | 189529610001 | |||||||||
| DWS DIRECTORS LIMITED | Administrateur désigné | Five Chancery Lane Cliffords Inn EC4A 1BU London | 900023830001 | |||||||||||
| EUROPA DIRECTOR LIMITED | Administrateur | Europa House 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough North Yorkshire | 102560510001 |
COLERIDGE (NO.25) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 22 mars 2012 Livré le 30 mars 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of accession and charge | Créé le 28 août 2009 Livré le 11 sept. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the charging company’s and any other chargor’s indebtedness to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All land in england and wales,all its rights at the accession deed date,all trade debts and other debts see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deposit deed | Créé le 24 mars 2004 Livré le 03 avr. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti £711,755.70 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The deposit balance being initially £711,755.70 and other sums forming the deposit balance. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 23 juil. 2003 Livré le 30 juil. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 23 juil. 2003 Livré le 30 juil. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of legal mortgage all the l/h property known as caddis house, cahill house and invicta house, waterfront business park, fleet, hampshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
COLERIDGE (NO.25) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0