AVL (PUBS) NO.2 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAVL (PUBS) NO.2 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04807691
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AVL (PUBS) NO.2 LIMITED ?

    • Restaurants avec licence (56101) / Hébergement et restauration
    • Débits de boissons et bars (56302) / Hébergement et restauration

    Où se situe AVL (PUBS) NO.2 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Resolve Advisory Limited
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AVL (PUBS) NO.2 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FLOWERCHANCE LIMITED23 juin 200323 juin 2003

    Quels sont les derniers comptes de AVL (PUBS) NO.2 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 avr. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour AVL (PUBS) NO.2 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 janv. 2021

    10 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom à Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU le 28 janv. 2020

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 16 janv. 2020

    LRESSP

    État du capital au 30 déc. 2019

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 avr. 2018

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Mr Richard Smothers en tant qu'administrateur le 31 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kirk Dyson Davis en tant que directeur le 31 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2017

    11 pagesAA

    Notification de Avl (Pubs) No. 1 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 01 mai 2016

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 juin 2016

    État du capital au 23 juin 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomination de Lindsay Anne Keswick en tant que secrétaire le 25 avr. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Claire Susan Stewart en tant que secrétaire le 25 avr. 2016

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ à Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT le 07 mars 2016

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 22 août 2015

    3 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de AVL (PUBS) NO.2 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Secrétaire
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    207524000001
    SMOTHERS, Richard
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Administrateur
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector242658700001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180591860001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172444830001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEVENS, Mark
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    Secrétaire
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    BritishCompany Secretary80951870001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181022200001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Secrétaire
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    BritishCompany Secretary135181230001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector164754670001
    CRICHTON, Roger Wells
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director67937290001
    CUMMING, Johanna Louise
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    Administrateur
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    United KingdomBritishDirector111108910001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant152083750001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector158484730001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141395280001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector170184800001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Administrateur
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritishCompany Director47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant86246470001
    KNIGHT, Andrew Ronald
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    Administrateur
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    BritishCompany Director81555100002
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector135408140001
    LESLIE, John Stewart
    Bec House Church End
    HP27 9PD Bledlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Bec House Church End
    HP27 9PD Bledlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director59934350001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector42019620001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector63043630002
    RIKLIN, Cornel Carl
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    Administrateur
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    EnglandSwissManaging Director78412270001
    RIPPER, Christopher
    Hillroft House
    Main Street Upper Stowe
    NN7 4SH Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Hillroft House
    Main Street Upper Stowe
    NN7 4SH Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director97847560001
    SMITH, Benedict James
    Flat 9
    62 Eccleston Square
    SW1V 1PH London
    Administrateur
    Flat 9
    62 Eccleston Square
    SW1V 1PH London
    United KingdomBritishCompany Director75231110001
    STONE, Stephen John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton-On-Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton-On-Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131652460001
    SYMONDS, Paul
    Willow House
    10a Vicars Close, Biddenham
    MK40 4BG Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    Willow House
    10a Vicars Close, Biddenham
    MK40 4BG Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishCompany Director80167420001
    THORLEY, Giles Alexander
    Charlton Manor
    Ashley Road Charlton Kings
    GL52 6NS Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Charlton Manor
    Ashley Road Charlton Kings
    GL52 6NS Cheltenham
    Gloucestershire
    Gb-EngBritishDirector81928120001
    TURPIN, Nigel Richard
    The Granary
    Cross Hill, Brixworth
    NN6 9DB Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    The Granary
    Cross Hill, Brixworth
    NN6 9DB Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director63410670001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AVL (PUBS) NO.2 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Avl (Pubs) No. 1 Limited
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St. Edmunds
    Westgate Brewery
    England
    06 avr. 2016
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St. Edmunds
    Westgate Brewery
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies Registry
    Numéro d'enregistrement04807720
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    AVL (PUBS) NO.2 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 15 déc. 2003
    Livré le 31 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    3 one 7, london t/n NGL413494. Antelope inn, bangor f/h t/n CYM802. Barbridge inn, barbridge f/h t/n CH149639 for details of further property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transactions
    • 31 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juin 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 03 nov. 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 09 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    AVL (PUBS) NO.2 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 janv. 2020Commencement of winding up
    24 avr. 2022Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon Jagger
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    practitioner
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    practitioner
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0