VERMILION SOFTWARE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVERMILION SOFTWARE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04812491
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VERMILION SOFTWARE LIMITED ?

    • Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques n.c.a. (74909) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe VERMILION SOFTWARE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Broadgate Quarter
    1 Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de VERMILION SOFTWARE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VERMILION SOFTWARE PLC26 juin 200326 juin 2003

    Quels sont les derniers comptes de VERMILION SOFTWARE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour VERMILION SOFTWARE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Nomination de Allan Verman Yap Ong en tant qu'administrateur le 12 oct. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Goran Skoko en tant que directeur le 11 oct. 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alan Bettridge en tant que directeur le 10 sept. 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes annuels établis au 31 août 2020

    17 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 16 avr. 2021

    • Capital: GBP 0.01
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 31/03/2021
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Frederick Philip Snow en tant que directeur le 29 janv. 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Rachel Rebecca Stern en tant que secrétaire le 29 janv. 2021

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 août 2019

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Goran Skoko le 24 sept. 2019

    2 pagesCH01

    Nomination de Alan Bettridge en tant qu'administrateur le 24 sept. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Goran Skoko en tant qu'administrateur le 24 sept. 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 août 2018

    21 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Carl Burton en tant que directeur le 28 févr. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mark Dell'isola en tant qu'administrateur le 07 oct. 2018

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de VERMILION SOFTWARE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DELL'ISOLA, Mark Anthony
    1 Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter
    England
    Administrateur
    1 Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter
    England
    United StatesAmerican186761640001
    ONG, Allan Verman Yap
    1 Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter
    England
    Administrateur
    1 Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter
    England
    PhilippinesFilipino288211430001
    SHAN, Helen
    1 Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter
    England
    Administrateur
    1 Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter
    England
    United StatesAmerican251232250001
    CORNWELL, Simon Paul Anthony
    4 The Potteries
    Ottershaw
    KT16 0HF Chertsey
    Surrey
    Secrétaire
    4 The Potteries
    Ottershaw
    KT16 0HF Chertsey
    Surrey
    British86622940001
    OSBORNE, David Simon
    Craneswood
    Knowle Lane
    GU6 8JN Cranleigh
    Surrey
    Secrétaire
    Craneswood
    Knowle Lane
    GU6 8JN Cranleigh
    Surrey
    British40742110001
    STERN, Rachel Rebecca
    1 Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter
    England
    Secrétaire
    1 Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter
    England
    218660410001
    DAND CARNEGIE ACCOUNTING SOLUTIONS LIMITED
    90-92 Queen Street
    Broughty Ferry
    DD5 1NB Dundee
    Spalding House
    Angus
    United Kingdom
    Secrétaire
    90-92 Queen Street
    Broughty Ferry
    DD5 1NB Dundee
    Spalding House
    Angus
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC288243
    118913980001
    SLC REGISTRARS LIMITED
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    Secrétaire
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    34893920001
    BEER, Alan Clive
    8 Inman Road
    Earlsfield
    SW18 3BB London
    Administrateur
    8 Inman Road
    Earlsfield
    SW18 3BB London
    EnglandBritish45038350008
    BETTRIDGE, Alan
    1 Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter
    England
    Administrateur
    1 Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter
    England
    Hong KongBritish262976530001
    BURTON, Andrew Carl
    1 Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter
    England
    Administrateur
    1 Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter
    England
    EnglandBritish189607730001
    CARNEGIE, James Derek Scott
    51 Cedar Road
    Broughty Ferry
    DD5 3BA Dundee
    Angus
    Administrateur
    51 Cedar Road
    Broughty Ferry
    DD5 3BA Dundee
    Angus
    ScotlandBritish106430003
    CORNWELL, Simon Paul Anthony
    4 The Potteries
    Ottershaw
    KT16 0HF Chertsey
    Surrey
    Administrateur
    4 The Potteries
    Ottershaw
    KT16 0HF Chertsey
    Surrey
    United KingdomBritish86622940001
    MITCHELL, Stuart James
    North Platt Crescent
    Ratho
    EH28 8JT Newbridge
    21
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    North Platt Crescent
    Ratho
    EH28 8JT Newbridge
    21
    Midlothian
    Scotland
    United KingdomBritish165110060002
    MURPHY, Simon
    33 Prescott Avenue
    Petts Wood
    BR5 1AE Orpington
    Kent
    Administrateur
    33 Prescott Avenue
    Petts Wood
    BR5 1AE Orpington
    Kent
    EnglandBritish58771770001
    NICOLELLI, Maurizio
    1 Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter
    England
    Administrateur
    1 Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter
    England
    United StatesAmerican183619170001
    NOBLE, Marcus
    Midton Of Fullwood
    KA3 5JZ Stewarton
    Administrateur
    Midton Of Fullwood
    KA3 5JZ Stewarton
    United KingdomUnited Kingdom241534480001
    OSBORNE, David Simon
    Craneswood
    Knowle Lane
    GU6 8JN Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    Craneswood
    Knowle Lane
    GU6 8JN Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritish40742110001
    SKOKO, Goran
    1 Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter
    England
    Administrateur
    1 Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter
    England
    EnglandAmerican262570900002
    SNOW, Frederick Philip
    1 Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter
    England
    Administrateur
    1 Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter
    England
    United StatesAmerican230965990001
    SLC CORPORATE SERVICES LIMITED
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    Administrateur
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    74654310001
    SLC REGISTRARS LIMITED
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    Administrateur
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    34893920001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur VERMILION SOFTWARE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Factset Research Systems Inc.
    Norwalk
    Connecticut
    601 Merritt 7
    United States
    05 mars 2018
    Norwalk
    Connecticut
    601 Merritt 7
    United States
    Non
    Forme juridiqueGeneral Corporation
    Autorité légaleGeneral Corporation Law Of The State Of Delaware
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Vermilion Holdings Limited
    Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter,1 Snowden Street London,England
    England
    08 nov. 2016
    Snowden Street
    EC2A 2DQ London
    Broadgate Quarter,1 Snowden Street London,England
    England
    Oui
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleUk Companies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUk Companies House
    Numéro d'enregistrementSc291814
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    VERMILION SOFTWARE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 11 nov. 2013
    Livré le 25 nov. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Maven Capital Partners UK LLP (As Agent and Trustee)
    Transactions
    • 25 nov. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 22 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 11 nov. 2013
    Livré le 20 nov. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All freehold and leasehold land, intellectual property and chattels of the company on the date of the instrument or at any time afterwards, as more fully described in the instrument (although no land, ship, aircraft or intellectual property registered (or required to be registered) in the UK is specifically detailed in the instrument as being subject to a fixed charge or fixed security under the instrument).. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 20 nov. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 nov. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 14 janv. 2013
    Livré le 16 janv. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £37,800.00 and all other monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £37,800.00.
    Personnes ayant droit
    • The Mount Stuart Trust
    Transactions
    • 16 janv. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 30 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 14 janv. 2008
    Livré le 17 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The initial amount being £38,850 plus vat and all monies from time to time standing to the account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • British Overseas Bank Nominees Limited
    Transactions
    • 17 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 10 août 2006
    Livré le 16 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right and interest in the account,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hitwise UK Limited
    Transactions
    • 16 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 08 mai 2006
    Livré le 13 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture deed
    Créé le 09 nov. 2004
    Livré le 13 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0