VERMILION SOFTWARE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | VERMILION SOFTWARE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04812491 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe VERMILION SOFTWARE LIMITED ?
| Adresse du siège social | Broadgate Quarter 1 Snowden Street EC2A 2DQ London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de VERMILION SOFTWARE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 août 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour VERMILION SOFTWARE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
Nomination de Allan Verman Yap Ong en tant qu'administrateur le 12 oct. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Goran Skoko en tant que directeur le 11 oct. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Alan Bettridge en tant que directeur le 10 sept. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2021 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 août 2020 | 17 pages | AA | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||||||
legacy | 2 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 16 avr. 2021
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Frederick Philip Snow en tant que directeur le 29 janv. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Rachel Rebecca Stern en tant que secrétaire le 29 janv. 2021 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 août 2019 | 21 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Goran Skoko le 24 sept. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Nomination de Alan Bettridge en tant qu'administrateur le 24 sept. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Goran Skoko en tant qu'administrateur le 24 sept. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 août 2018 | 21 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Carl Burton en tant que directeur le 28 févr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mark Dell'isola en tant qu'administrateur le 07 oct. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de VERMILION SOFTWARE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL'ISOLA, Mark Anthony | Administrateur | 1 Snowden Street EC2A 2DQ London Broadgate Quarter England | United States | American | 186761640001 | |||||||||
| ONG, Allan Verman Yap | Administrateur | 1 Snowden Street EC2A 2DQ London Broadgate Quarter England | Philippines | Filipino | 288211430001 | |||||||||
| SHAN, Helen | Administrateur | 1 Snowden Street EC2A 2DQ London Broadgate Quarter England | United States | American | 251232250001 | |||||||||
| CORNWELL, Simon Paul Anthony | Secrétaire | 4 The Potteries Ottershaw KT16 0HF Chertsey Surrey | British | 86622940001 | ||||||||||
| OSBORNE, David Simon | Secrétaire | Craneswood Knowle Lane GU6 8JN Cranleigh Surrey | British | 40742110001 | ||||||||||
| STERN, Rachel Rebecca | Secrétaire | 1 Snowden Street EC2A 2DQ London Broadgate Quarter England | 218660410001 | |||||||||||
| DAND CARNEGIE ACCOUNTING SOLUTIONS LIMITED | Secrétaire | 90-92 Queen Street Broughty Ferry DD5 1NB Dundee Spalding House Angus United Kingdom |
| 118913980001 | ||||||||||
| SLC REGISTRARS LIMITED | Secrétaire | 42-46 High Street KT10 9QY Esher Surrey | 34893920001 | |||||||||||
| BEER, Alan Clive | Administrateur | 8 Inman Road Earlsfield SW18 3BB London | England | British | 45038350008 | |||||||||
| BETTRIDGE, Alan | Administrateur | 1 Snowden Street EC2A 2DQ London Broadgate Quarter England | Hong Kong | British | 262976530001 | |||||||||
| BURTON, Andrew Carl | Administrateur | 1 Snowden Street EC2A 2DQ London Broadgate Quarter England | England | British | 189607730001 | |||||||||
| CARNEGIE, James Derek Scott | Administrateur | 51 Cedar Road Broughty Ferry DD5 3BA Dundee Angus | Scotland | British | 106430003 | |||||||||
| CORNWELL, Simon Paul Anthony | Administrateur | 4 The Potteries Ottershaw KT16 0HF Chertsey Surrey | United Kingdom | British | 86622940001 | |||||||||
| MITCHELL, Stuart James | Administrateur | North Platt Crescent Ratho EH28 8JT Newbridge 21 Midlothian Scotland | United Kingdom | British | 165110060002 | |||||||||
| MURPHY, Simon | Administrateur | 33 Prescott Avenue Petts Wood BR5 1AE Orpington Kent | England | British | 58771770001 | |||||||||
| NICOLELLI, Maurizio | Administrateur | 1 Snowden Street EC2A 2DQ London Broadgate Quarter England | United States | American | 183619170001 | |||||||||
| NOBLE, Marcus | Administrateur | Midton Of Fullwood KA3 5JZ Stewarton | United Kingdom | United Kingdom | 241534480001 | |||||||||
| OSBORNE, David Simon | Administrateur | Craneswood Knowle Lane GU6 8JN Cranleigh Surrey | England | British | 40742110001 | |||||||||
| SKOKO, Goran | Administrateur | 1 Snowden Street EC2A 2DQ London Broadgate Quarter England | England | American | 262570900002 | |||||||||
| SNOW, Frederick Philip | Administrateur | 1 Snowden Street EC2A 2DQ London Broadgate Quarter England | United States | American | 230965990001 | |||||||||
| SLC CORPORATE SERVICES LIMITED | Administrateur | 42-46 High Street KT10 9QY Esher Surrey | 74654310001 | |||||||||||
| SLC REGISTRARS LIMITED | Administrateur | 42-46 High Street KT10 9QY Esher Surrey | 34893920001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur VERMILION SOFTWARE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factset Research Systems Inc. | 05 mars 2018 | Norwalk Connecticut 601 Merritt 7 United States | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Vermilion Holdings Limited | 08 nov. 2016 | Snowden Street EC2A 2DQ London Broadgate Quarter,1 Snowden Street London,England England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
VERMILION SOFTWARE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 11 nov. 2013 Livré le 25 nov. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 11 nov. 2013 Livré le 20 nov. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All freehold and leasehold land, intellectual property and chattels of the company on the date of the instrument or at any time afterwards, as more fully described in the instrument (although no land, ship, aircraft or intellectual property registered (or required to be registered) in the UK is specifically detailed in the instrument as being subject to a fixed charge or fixed security under the instrument).. Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 14 janv. 2013 Livré le 16 janv. 2013 | Totalement satisfaite | Montant garanti £37,800.00 and all other monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions £37,800.00. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 14 janv. 2008 Livré le 17 janv. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The initial amount being £38,850 plus vat and all monies from time to time standing to the account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 10 août 2006 Livré le 16 août 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All right and interest in the account,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 08 mai 2006 Livré le 13 mai 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture deed | Créé le 09 nov. 2004 Livré le 13 nov. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0