UNION PROPERTIES (KX) LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéUNION PROPERTIES (KX) LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04817732
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de UNION PROPERTIES (KX) LTD ?

    • Activités des agents immobiliers (68310) / Activités immobilières

    Où se situe UNION PROPERTIES (KX) LTD ?

    Adresse du siège social
    Robert Day And Company Limited The Old Library
    The Walk
    MK18 3AJ Winslow
    Buckingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de UNION PROPERTIES (KX) LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour UNION PROPERTIES (KX) LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    9 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 févr. 2017

    7 pages4.68

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2015

    6 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 13 Vansittart Estate Windsor Berkshire SL4 1SE à Robert Day and Company Limited the Old Library the Walk Winslow Buckingham MK18 3AJ le 04 mars 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 23 févr. 2016

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 sept. 2015

    État du capital au 08 sept. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2014

    7 pagesAA

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 1

    2 pagesMR05

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    2 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 août 2014

    État du capital au 05 août 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2013

    7 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 oct. 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 30 oct. 2013

    SH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2012

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    11 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2009

    5 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 11a Vansittart Estate Windsor Berkshire SL4 1SE* le 11 nov. 2009

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de UNION PROPERTIES (KX) LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PLOUTARHOU, Christopher
    90 The Mall
    N14 6LP Southgate
    Secrétaire
    90 The Mall
    N14 6LP Southgate
    BritishArchitect32959140004
    PLOUTARHOU, Christopher
    90 The Mall
    N14 6LP Southgate
    Administrateur
    90 The Mall
    N14 6LP Southgate
    United KingdomBritishArchitect32959140004
    ROONEY, Patrick James
    Whitecrofts
    Croft Mews Woodside Park
    N12 8TR London
    Administrateur
    Whitecrofts
    Croft Mews Woodside Park
    N12 8TR London
    United KingdomBritishProject Management79923460003
    ACE SECRETARIES LIMITED
    869 High Road
    North Finchley
    N12 8QA London
    Secrétaire
    869 High Road
    North Finchley
    N12 8QA London
    83287070001
    ACE REGISTRARS LIMITED
    869 High Road
    North Finchley
    N12 8QA London
    Administrateur
    869 High Road
    North Finchley
    N12 8QA London
    72067280002

    UNION PROPERTIES (KX) LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of subordination
    Créé le 30 juin 2005
    Livré le 20 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Upon an insolvency event occurring in respect of the debtor the junior creditor will hold on trust for northern rock and pay over to the northern rock on demand any sums received by it in respect of the subordinated liabilities until all the senior liabilities have been repaid in full.
    Personnes ayant droit
    • Northern Rock PLC
    Transactions
    • 20 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 30 juin 2005
    Livré le 01 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Property being 2, 4, 6 acton street, london t/no NGL673543, and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale.assigned to the lender the related rights.fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery.floating charge the undertaking all property and assets.assigned the goodwill and the intellectual property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Northern Rock PLC
    Transactions
    • 01 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 31 oct. 2003
    Livré le 15 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the freehold and leasehold property now vested in or charged to the company being the prince albert public house 2 & 4 acton street and land lying to the west of kings cross road camden t/n NGL804561 and NGL673543. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 31 oct. 2003
    Livré le 15 nov. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property being the prince albert public house 2 & 4 acton street and land lying to the west of kings cross road camden t/no.s NGL804561 and NGL673543. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 oct. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)

    UNION PROPERTIES (KX) LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    13 juin 2018Due to be dissolved on
    23 févr. 2016Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert Day
    The Old Library The Walk
    MK18 3AJ Winslow
    Buckinghamshire
    practitioner
    The Old Library The Walk
    MK18 3AJ Winslow
    Buckinghamshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0