OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOPAL PORTFOLIO 3 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04824858
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Administration de biens immobiliers pour compte de tiers (68320) / Activités immobilières

    Où se situe OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 sept. 2018

    7 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 sept. 2017

    7 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de The Place Ducie Street Manchester M1 2TP à 15 Canada Square London E14 5GL le 20 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 sept. 2016

    LRESSP

    Avis d'achèvement de l'accord volontaire

    47 pages1.4

    Nomination de Mr Richard James Spencer en tant qu'administrateur le 04 juin 2015

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Brett Alan Lashley en tant que directeur le 04 juin 2015

    2 pagesTM01

    Nomination de Brett Alan Lashley en tant qu'administrateur le 25 févr. 2015

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Craig Allan Mellor en tant que directeur le 25 févr. 2015

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gavin Robert Duncan en tant que directeur le 25 févr. 2015

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Criag Allan Mellor en tant que secrétaire le 25 févr. 2015

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Stuart Barrie Wall en tant que directeur le 25 févr. 2015

    2 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Kpmg Llp 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB à The Place Ducie Street Manchester M1 2TP le 06 mars 2015

    2 pagesAD01

    Avis de fin de l'administration

    74 pages2.32B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 10 janv. 2015

    67 pages2.24B

    Avis au registre des sociétés de l'accord volontaire prenant effet

    9 pages1.1

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 10 juil. 2014

    90 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 10 janv. 2014

    65 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 17 sept. 2013

    77 pages2.24B

    Qui sont les dirigeants de OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SPENCER, Richard James
    Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court 133
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court 133
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish190526870001
    DRAPER, Abigail Sarah
    265 Chester Road, Helsby
    WA6 0PN Frodsham
    Cheshire
    Secrétaire
    265 Chester Road, Helsby
    WA6 0PN Frodsham
    Cheshire
    British107928180001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Secrétaire désigné
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    MELLOR, Criag Allan
    21 Queenston Road
    M20 2NX Manchester
    Lancashire
    Secrétaire
    21 Queenston Road
    M20 2NX Manchester
    Lancashire
    British100890520001
    DUNCAN, Gavin Robert
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Administrateur
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandBritish151512820001
    LASHLEY, Brett Alan
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Administrateur
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandUnited States Of America196201790001
    MARTIN, Graham Hunter
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British87259480001
    MELLOR, Craig Allan
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Administrateur
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandBritish60906780002
    SMITH, David Ryder
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    Administrateur
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    EnglandBritish202067380001
    WALL, Stuart Barrie
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95010340001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Administrateur désigné
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001

    OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Group debenture
    Créé le 04 avr. 2012
    Livré le 19 avr. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Pitfield street youth centre, pitfield street t/no EGL438260. Lyme view, 17 buxton road west, disley t/no CH519650. Land and buildings on the south east side of granby row t/no LA378335. (For further details of properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Bank Resolution Corporation Limited
    Transactions
    • 19 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 07 mai 2004
    Livré le 11 mai 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h land and buildings k/a condor works located on the north side of rusholme place, manchester t/n LA187336, by way of assignment the gross rents licence fees and other monies; by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transactions
    • 11 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 26 sept. 2003
    Livré le 10 oct. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage the f/h property k/a wilmslow park wilmslow road manchester t/no GM683090 and opal court de montfort street leicester t/no LT27667 and including all rights and buildings fixtures fittings plant and machinery, the gross rents licence fees and other monies receivable, the benefit of all guarantees and all and any agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 10 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 12 sept. 2003
    Livré le 25 sept. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 25 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 12 sept. 2003
    Livré le 25 sept. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 6 windsor villas lockyer street plymouth t/n DN362302, the f/h property k/a 6 windsor villas lockyer street plymouth t/n DN233238, the f/h property k/a phoenix house notte street plymouth and t/n DN303418. The gross rent licence fees and other monies , the benefit of all guarantees warranties and representations, the benefit of all and any agreements relating to the property and the goodwill. By way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 25 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)

    OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 mars 2013Administration started
    20 févr. 2015Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    practitioner
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    DateType
    12 déc. 2014Date of meeting to approve CVA
    22 oct. 2015Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Brian Green
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    4
    DateType
    30 sept. 2016Commencement of winding up
    22 août 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0