MONITISE EUROPE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MONITISE EUROPE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04831976 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MONITISE EUROPE LIMITED ?
| Adresse du siège social | 6 Snow Hill EC1A 2AY London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MONITISE EUROPE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MONITISE EUROPE LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation | |
|---|---|
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 nov. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour MONITISE EUROPE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 12 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 31 oct. 2023 | 12 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 31 oct. 2022 | 12 pages | LIQ03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Hunter en tant que directeur le 31 oct. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Simon Waller en tant que directeur le 30 sept. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de William Richard Jones en tant que directeur le 31 déc. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr. Craig William Gurney en tant qu'administrateur le 30 sept. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr. Stuart Kevin Forgan en tant qu'administrateur le 30 sept. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 7 pages | LIQ01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 2 New Bailey 6 Stanley Street Salford Greater Manchester M3 5GS United Kingdom à 6 Snow Hill London EC1A 2AY le 11 nov. 2021 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des détails de Monitise Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 juil. 2021 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES England à 2 New Bailey 6 Stanley Street Salford Greater Manchester M3 5GS le 01 juil. 2021 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 21 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 nov. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 30 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 nov. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr William Richard Jones le 06 avr. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 nov. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Arthur Spurgeon en tant que directeur le 31 juil. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Arthur Spurgeon en tant que secrétaire le 31 juil. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Thomas Hunter en tant qu'administrateur le 11 juil. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Medius House 2 Sheraton Street London W1F 8BH England à Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES le 09 févr. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MONITISE EUROPE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORGAN, Stuart Kevin, Mr. | Administrateur | Snow Hill EC1A 2AY London 6 | England | British | 295032390001 | |||||
| GURNEY, Craig William, Mr. | Administrateur | Snow Hill EC1A 2AY London 6 | England | British | 246013580001 | |||||
| BAXTER, Richard Alistair | Secrétaire | Little Stonborough Grovers Gardens GU26 6PT Hindhead Surrey | British | 50327050001 | ||||||
| CAMERON, Lee John Harcourt | Secrétaire | The Laurels 27 Berks Hill WD3 5AG Chorleywood Hertfordshire | British | 76251460006 | ||||||
| SPURGEON, Thomas Arthur | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House England | 203130300001 | |||||||
| SPURGEON, Thomas Arthur | Secrétaire | Gresham Street EC2V 7NA London 95 United Kingdom | British | 158713500001 | ||||||
| VIJAY ANAND, Priyanka | Secrétaire | Gresham Street EC2V 7NA London 95 United Kingdom | 184864130001 | |||||||
| WALLER, Richard | Secrétaire | 29 Throgmorton Street EC2N 2AT London Warnford Court | 146409410001 | |||||||
| BAXTER, Richard Alistair | Administrateur | Little Stonborough Grovers Gardens GU26 6PT Hindhead Surrey | British | 50327050001 | ||||||
| BERESFORD, David Michael | Administrateur | Otterbourne Road Compton SO21 2BB Winchester The Coach House Hampshire United Kingdom | England | British | 136196730001 | |||||
| CAMERON, Lee John Harcourt | Administrateur | 29 Throgmorton Street EC2N 2AT London Warnford Court | England | British | 76251460006 | |||||
| CAMERON, Lee John Harcourt | Administrateur | 58 Green Street WD3 5QR Chorleywood Hertfordshire | United Kingdom | British | 76251460003 | |||||
| FIELDHOUSE, Nicholas John Carpmael | Administrateur | 18 Furzefield Road RH2 7HG Reigate Surrey | U.K. | U.K. | 74928500001 | |||||
| GAUSDEN, Ian Andrew | Administrateur | Markington Hall Markington HG3 3PQ Harrogate | United Kingdom | British | 127932050001 | |||||
| GERRARD, Philip Martin | Administrateur | 80 Southway Guiseley LS20 8JQ Leeds West Yorkshire | England | British | 79563110001 | |||||
| GRIGG, Stephen Michael | Administrateur | Brindles Stockhall Grange High Street North LU7 0EP Stewkley Luton | United Kingdom | British | 111221800001 | |||||
| HUNTER, Thomas | Administrateur | Snow Hill EC1A 2AY London 6 | United Kingdom | British | 248751850001 | |||||
| JAMES, Gavin Keith, Mr. | Administrateur | Camelford Bradcutts Lane SL6 9AA Cookham Dean Berkshire | England | British | 44173560008 | |||||
| JONES, William Richard | Administrateur | Snow Hill EC1A 2AY London 6 | United Kingdom | British | 253980640001 | |||||
| KEARSLEY, Martin Jeremy | Administrateur | 29 Throgmorton Street EC2N 2AT London Warnford Court | United Kingdom | British | 146442080001 | |||||
| KEARSLEY, Martin Jeremy | Administrateur | Badgers Lodge Hogmoor Lane RG10 0DH Hurst Berkshire | United Kingdom | British | 146442080001 | |||||
| KEYWORTH, Michael Derek | Administrateur | Gresham Street EC2V 7NA London 95 United Kingdom | United Kingdom | British | 56989100002 | |||||
| LUKIES, Alastair David, Mr. | Administrateur | 29 Throgmorton Street EC2N 2AT London Warnford Court | England | British | 98003240002 | |||||
| PETZER, Bradley Mark | Administrateur | Gresham Street EC2V 7NA London 95 | United Kingdom | British | 82998740004 | |||||
| SHIELDS, Karl Andrew | Administrateur | Cheviot House Headwell Lane Saxton LS24 9PX Tadcaster North Yorkshire | England | British | 69641290001 | |||||
| SPURGEON, Thomas Arthur | Administrateur | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House England | England | British | 125542710003 | |||||
| SPURGEON, Thomas Arthur | Administrateur | 29 Throgmorton Street EC2N 2AT London Warnford Court | England | British | 125542710002 | |||||
| TAYLOR, Nicholas Charles Fraser | Administrateur | Gresham Street EC2V 7NA London 95 United Kingdom | United Kingdom | British | 170245660001 | |||||
| WALLER, Richard Simon | Administrateur | Snow Hill EC1A 2AY London 6 | United Kingdom | British | 173957320001 | |||||
| WILSON, Martin | Administrateur | 34 London Road WD7 9EN Shenley Hertfordshire | England | British | 97096300001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MONITISE EUROPE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitise Group Limited | 08 juin 2016 | New Bailey 6 Stanley Street M3 5GS Salford 2 Greater Manchester United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
MONITISE EUROPE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0