THINC ENTITIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHINC ENTITIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04836733
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THINC ENTITIES LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe THINC ENTITIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5 Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THINC ENTITIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THINC GROUP LIMITED17 juil. 200317 juil. 2003

    Quels sont les derniers comptes de THINC ENTITIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour THINC ENTITIES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour THINC ENTITIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 mai 2014

    État du capital au 15 mai 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nomination de David Richard Cheeseman en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Graham Harvey en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    3 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    3 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    État du capital au 27 déc. 2012

    • Capital: GBP 1.00
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Reduction of share premium account and miscellaneous reserve balance 27/12/2012
    RES13

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    6 pagesAA

    Nomination de Christopher Graham Bobby en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Philip Anderson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Graham Harvey en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Jeremy Peter Small le 23 avr. 2010

    1 pagesCH03

    Qui sont les dirigeants de THINC ENTITIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMALL, Jeremy Peter
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Secrétaire
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    British67168210001
    BOBBY, Christopher Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United KingdomBritish170592990001
    CHEESEMAN, David Richard
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    EnglandBritish132416500001
    HARKIN, Neil Michael
    White House
    Dunnington Common Dunnington
    YO19 5LS York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    White House
    Dunnington Common Dunnington
    YO19 5LS York
    North Yorkshire
    British146701610001
    RENNISON, Roderic Henry Patrick
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    British130449650001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    ANDERSON, Philip John
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    UkBritish79136250001
    BALDWIN, Keith Reginald
    Sandridge Lodge
    Bromham
    SN15 2JN Chippenham
    Wiltshire
    Administrateur
    Sandridge Lodge
    Bromham
    SN15 2JN Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritish7401430002
    BAYLISS, Keith Ronald
    3 Chesterford House
    28 Store Street
    WC1E 7BS London
    Administrateur
    3 Chesterford House
    28 Store Street
    WC1E 7BS London
    British55337400002
    BOYLE, Nicholas
    2 Mount Pleasant
    Stanmills
    BT9 5DS Belfast
    County Antrim
    Administrateur
    2 Mount Pleasant
    Stanmills
    BT9 5DS Belfast
    County Antrim
    British141649010001
    CHAMBERLAIN, Simon John
    Manor Cottage
    Crackington Haven
    EX23 0JG Bude
    Cornwall
    Administrateur
    Manor Cottage
    Crackington Haven
    EX23 0JG Bude
    Cornwall
    EnglandBritish133883740012
    EVERILL, Jonathon Robert Edwin
    Sandbanks Road
    BH14 8EY Poole
    277
    Dorset
    Administrateur
    Sandbanks Road
    BH14 8EY Poole
    277
    Dorset
    British105488120003
    HARKIN, Neil Michael
    White House
    Dunnington Common Dunnington
    YO19 5LS York
    North Yorkshire
    Administrateur
    White House
    Dunnington Common Dunnington
    YO19 5LS York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish146701610001
    HARRAGAN, Stephen William
    36 Birch Lane
    CM4 9NA Stock
    Essex
    Administrateur
    36 Birch Lane
    CM4 9NA Stock
    Essex
    United KingdomBritish16510590003
    HARVEY, Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United KingdomBritish168974600001
    PIERCE, Raymond Francis
    St Wilfreds 42 Ferndale Road
    RH15 0HG Burgess Hill
    West Sussex
    Administrateur
    St Wilfreds 42 Ferndale Road
    RH15 0HG Burgess Hill
    West Sussex
    EnglandBritish3231870001
    RENNISON, Roderic Henry Patrick
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    Administrateur
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    EnglandBritish130449650001
    TAYLOR, Gregg
    Meadowvale
    Wellington Hill, High Beach
    IG10 4AH Loughton
    Essex
    Administrateur
    Meadowvale
    Wellington Hill, High Beach
    IG10 4AH Loughton
    Essex
    United KingdomBritish93705800003
    TROTTER, Timothy Hugh Southcombe
    Field Burcote House
    Duncote
    NN12 8AH Towcester
    Northamptonshire
    Administrateur
    Field Burcote House
    Duncote
    NN12 8AH Towcester
    Northamptonshire
    United KingdomBritish86031170001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    THINC ENTITIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over shares
    Créé le 25 nov. 2005
    Livré le 10 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Right, title and interest in and to the shares and any securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over shares
    Créé le 25 nov. 2005
    Livré le 08 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of second fixed charge its entire right title and interest in and to the shares and to any securities and all dividends monies and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Prudential UK Services Limited
    Transactions
    • 08 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 nov. 2005
    Livré le 08 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other group company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property k/a the guard house, fulford road, york, level 2 vitners place, 68 upper thames street, london, park house west, heatcote road, camberley t/no SY741619 for further property charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Prudential UK Services Limited
    Transactions
    • 08 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 21 oct. 2004
    Livré le 26 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £10,674.
    Personnes ayant droit
    • The Trustees of the National Heritage Memorial Fund
    Transactions
    • 26 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of debts by way of security
    Créé le 05 oct. 2004
    Livré le 21 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or thinc finance limited to the charge on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the future rights, titles and interests in and benefits of the company whatsoever in the debts, together with the benefit of any and all intermediary contracts or agency agreements.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over cash deposit
    Créé le 05 oct. 2004
    Livré le 21 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All sums (denominated in whatever currency) together with all interest and other amounts accruing on such sums for the time being and from time to time standing to the credit of the bank account of the company with bos. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 mai 2004
    Livré le 21 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 févr. 2004
    Livré le 26 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0