THINC ENTITIES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | THINC ENTITIES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04836733 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THINC ENTITIES LIMITED ?
| Adresse du siège social | 5 Old Broad Street EC2N 1AD London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THINC ENTITIES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2012 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour THINC ENTITIES LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour THINC ENTITIES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination de David Richard Cheeseman en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Graham Harvey en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Démission de l'auditeur | 2 pages | AUD | ||||||||||||||
Démission de l'auditeur | 3 pages | AUD | ||||||||||||||
Démission de l'auditeur | 3 pages | AUD | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 11 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
État du capital au 27 déc. 2012
| 5 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 6 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Christopher Graham Bobby en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Philip Anderson en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
Nomination de Graham Harvey en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2009 | 13 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Jeremy Peter Small le 23 avr. 2010 | 1 pages | CH03 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de THINC ENTITIES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALL, Jeremy Peter | Secrétaire | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | British | 67168210001 | ||||||
| BOBBY, Christopher Graham | Administrateur | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | United Kingdom | British | 170592990001 | |||||
| CHEESEMAN, David Richard | Administrateur | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | England | British | 132416500001 | |||||
| HARKIN, Neil Michael | Secrétaire | White House Dunnington Common Dunnington YO19 5LS York North Yorkshire | British | 146701610001 | ||||||
| RENNISON, Roderic Henry Patrick | Secrétaire | Westmill Lane Ickleford SG5 3RP Hitchin Old Westmill Farmhouse Hertfordshire | British | 130449650001 | ||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| ANDERSON, Philip John | Administrateur | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | Uk | British | 79136250001 | |||||
| BALDWIN, Keith Reginald | Administrateur | Sandridge Lodge Bromham SN15 2JN Chippenham Wiltshire | England | British | 7401430002 | |||||
| BAYLISS, Keith Ronald | Administrateur | 3 Chesterford House 28 Store Street WC1E 7BS London | British | 55337400002 | ||||||
| BOYLE, Nicholas | Administrateur | 2 Mount Pleasant Stanmills BT9 5DS Belfast County Antrim | British | 141649010001 | ||||||
| CHAMBERLAIN, Simon John | Administrateur | Manor Cottage Crackington Haven EX23 0JG Bude Cornwall | England | British | 133883740012 | |||||
| EVERILL, Jonathon Robert Edwin | Administrateur | Sandbanks Road BH14 8EY Poole 277 Dorset | British | 105488120003 | ||||||
| HARKIN, Neil Michael | Administrateur | White House Dunnington Common Dunnington YO19 5LS York North Yorkshire | United Kingdom | British | 146701610001 | |||||
| HARRAGAN, Stephen William | Administrateur | 36 Birch Lane CM4 9NA Stock Essex | United Kingdom | British | 16510590003 | |||||
| HARVEY, Graham | Administrateur | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | United Kingdom | British | 168974600001 | |||||
| PIERCE, Raymond Francis | Administrateur | St Wilfreds 42 Ferndale Road RH15 0HG Burgess Hill West Sussex | England | British | 3231870001 | |||||
| RENNISON, Roderic Henry Patrick | Administrateur | Westmill Lane Ickleford SG5 3RP Hitchin Old Westmill Farmhouse Hertfordshire | England | British | 130449650001 | |||||
| TAYLOR, Gregg | Administrateur | Meadowvale Wellington Hill, High Beach IG10 4AH Loughton Essex | United Kingdom | British | 93705800003 | |||||
| TROTTER, Timothy Hugh Southcombe | Administrateur | Field Burcote House Duncote NN12 8AH Towcester Northamptonshire | United Kingdom | British | 86031170001 | |||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
THINC ENTITIES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over shares | Créé le 25 nov. 2005 Livré le 10 déc. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Right, title and interest in and to the shares and any securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over shares | Créé le 25 nov. 2005 Livré le 08 déc. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company or any other group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of second fixed charge its entire right title and interest in and to the shares and to any securities and all dividends monies and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 25 nov. 2005 Livré le 08 déc. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company or any other group company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The property k/a the guard house, fulford road, york, level 2 vitners place, 68 upper thames street, london, park house west, heatcote road, camberley t/no SY741619 for further property charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 21 oct. 2004 Livré le 26 oct. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions £10,674. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignment of debts by way of security | Créé le 05 oct. 2004 Livré le 21 oct. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or thinc finance limited to the charge on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All the future rights, titles and interests in and benefits of the company whatsoever in the debts, together with the benefit of any and all intermediary contracts or agency agreements. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over cash deposit | Créé le 05 oct. 2004 Livré le 21 oct. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All sums (denominated in whatever currency) together with all interest and other amounts accruing on such sums for the time being and from time to time standing to the credit of the bank account of the company with bos. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 19 mai 2004 Livré le 21 mai 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 19 févr. 2004 Livré le 26 févr. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0