NEVIS NO. 2 (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNEVIS NO. 2 (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04840981
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NEVIS NO. 2 (UK) LIMITED ?

    • Construction de bâtiments résidentiels (41202) / Construction

    Où se situe NEVIS NO. 2 (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    7 Crown Yard Bedgebury Road
    Goudhurst
    TN17 2QZ Cranbrook
    Kent
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NEVIS NO. 2 (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    04840981 LIMITED28 mars 202228 mars 2022

    Quels sont les derniers comptes de NEVIS NO. 2 (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour NEVIS NO. 2 (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 22 juil. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Notification de Paul Sellars en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mars 2022

    2 pagesPSC01

    Notification de Edward Craddock Belcher en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mars 2022

    2 pagesPSC01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed 04840981 LIMITED\certificate issued on 13/05/22
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name13 mai 2022

    Avis de changement de nom"

    CONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Company business/change of registered office address 08/04/2022
    RES13

    Changement d'adresse du siège social de Unit 430, 5 Spur Road Unit 430 5 Spur Road Isleworth Middlesex TW7 5BD England à 7 Crown Yard Bedgebury Road Goudhurst Cranbrook Kent TN17 2QZ le 04 mai 2022

    1 pagesAD01

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2021

    3 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2020

    3 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2019

    3 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2018

    3 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2017

    3 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2016

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 juil. 2021 sans mise à jour

    2 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 22 juil. 2020 sans mise à jour

    2 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 22 juil. 2019 sans mise à jour

    2 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 22 juil. 2018 sans mise à jour

    2 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 22 juil. 2017 sans mise à jour

    2 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 22 juil. 2016 sans mise à jour

    2 pagesCS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    19 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 mars 2022

    État du capital au 28 mars 2022

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Demande de rétablissement administratif

    4 pagesRT01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed nevis investment company\certificate issued on 28/03/22
    pagesCERTNM

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Qui sont les dirigeants de NEVIS NO. 2 (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BELCHER, Edward Craddock
    242 South Ealing Road
    Ealing
    W5 4RP London
    Secrétaire
    242 South Ealing Road
    Ealing
    W5 4RP London
    Australian49651510002
    BELCHER, Edward Craddock
    242 South Ealing Road
    Ealing
    W5 4RP London
    Administrateur
    242 South Ealing Road
    Ealing
    W5 4RP London
    United KingdomAustralian49651510002
    PEMEX SERVICES LIMITED
    Vanterpool Plaza
    Wickhams Quay 1, Road Town
    FOREIGN Tortola
    British Virgin Islands
    Secrétaire désigné
    Vanterpool Plaza
    Wickhams Quay 1, Road Town
    FOREIGN Tortola
    British Virgin Islands
    900031160001
    BELCHER, Amy
    242 South Ealing Road
    W5 4RP London
    Administrateur
    242 South Ealing Road
    W5 4RP London
    Australia93112680001
    SELLARS, Paul
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    Administrateur
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    EnglandBritish50761250001
    AMERSHAM SERVICES LIMITED
    Vanterpool Plaza
    Wickhams Quay 1, Road Town
    FOREIGN Tortola
    British Virgin Islands
    Administrateur désigné
    Vanterpool Plaza
    Wickhams Quay 1, Road Town
    FOREIGN Tortola
    British Virgin Islands
    900031180001
    PEMEX SERVICES LIMITED
    Vanterpool Plaza
    Wickhams Quay 1, Road Town
    FOREIGN Tortola
    British Virgin Islands
    Administrateur désigné
    Vanterpool Plaza
    Wickhams Quay 1, Road Town
    FOREIGN Tortola
    British Virgin Islands
    900031160001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NEVIS NO. 2 (UK) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Paul Sellars
    Bedgebury Road
    Goudhurst
    TN17 2QZ Cranbrook
    7 Crown Yard
    Kent
    28 mars 2022
    Bedgebury Road
    Goudhurst
    TN17 2QZ Cranbrook
    7 Crown Yard
    Kent
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Mr Edward Craddock Belcher
    Bedgebury Road
    Goudhurst
    TN17 2QZ Cranbrook
    7 Crown Yard
    Kent
    28 mars 2022
    Bedgebury Road
    Goudhurst
    TN17 2QZ Cranbrook
    7 Crown Yard
    Kent
    Non
    Nationalité: Australian
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    NEVIS NO. 2 (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 07 juil. 2006
    Livré le 21 juil. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    32 & 34 albion street newark on trent nottinghamshire and 242 south ealing road ealing london, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 21 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 07 juil. 2006
    Livré le 15 juil. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property known as 242 south ealing road ealing london t/n MX440229,. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 15 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 07 juil. 2006
    Livré le 15 juil. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property known as 32 and 34 albion street newark on trent notts t/n NT397141 and NT393354,. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 15 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 01 juin 2006
    Livré le 07 juin 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage
    Créé le 11 janv. 2006
    Livré le 12 janv. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 34 albion street newark t/n NT393354. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage
    Créé le 21 déc. 2004
    Livré le 23 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 32 albion street newark t/no NT397141. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 23 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0