AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED

AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04895923
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5 Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AVERY WEIGH-TRONIX NO. 1 LIMITED11 sept. 200311 sept. 2003

    Quels sont les derniers comptes de AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 09 oct. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    21 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 13 déc. 2019

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 11 sept. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Statuts

    23 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Transitional provisions and savings 05/06/2019
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    État du capital après une attribution d'actions au 05 juin 2019

    • Capital: GBP 8,682,075
    4 pagesSH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    21 pagesAA

    Nomination de Ryan Ronald Dale en tant que secrétaire le 18 déc. 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Philip Matthew Deakin en tant que directeur le 30 oct. 2017

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen James Rowell le 12 oct. 2017

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 11 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    20 pagesAA

    Cessation de la nomination de Edward Ufland en tant que directeur le 13 mars 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 11 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Stephen James Rowell en tant qu'administrateur le 01 avr. 2016

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    22 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DALE, Ryan Ronald
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    Secrétaire
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    241474930001
    S & J REGISTRARS LIMITED
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Secrétaire
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement01740543
    132600000001
    HUDSON, Giles Matthew
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Administrateur
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    United KingdomBritish161583790003
    ROWELL, Stephen James
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    Administrateur
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    United KingdomBritish208316380001
    FOGARTY, Robert Joseph
    April Cottage Manor Lane
    Little Comberton
    WR10 3ER Pershore
    Worcestershire
    Secrétaire
    April Cottage Manor Lane
    Little Comberton
    WR10 3ER Pershore
    Worcestershire
    British17437720002
    TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secrétaire
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    84071220001
    BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    EnglandBritish,Portuguese140644240001
    BOWE, Gerald Grant
    85 Pasquaney Lane
    Bridgewater
    Nh 03222
    Usa
    Administrateur
    85 Pasquaney Lane
    Bridgewater
    Nh 03222
    Usa
    American86912720003
    CRAMER, Carl, Mr.
    2 Little Dormers
    South Park Crescent
    SL9 8HJ Gerrards Cross
    Administrateur
    2 Little Dormers
    South Park Crescent
    SL9 8HJ Gerrards Cross
    United KingdomBritish92710960001
    DEAKIN, Philip Matthew
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Administrateur
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    United KingdomBritish146225080003
    UDALL, Gavin
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish83889580001
    UFLAND, Edward
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Administrateur
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    EnglandBritish161583570001
    HUNTSMOOR LIMITED
    Carmelite 50 Victoria Embankment
    Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Administrateur
    Carmelite 50 Victoria Embankment
    Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    39090660001
    HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment
    EC4Y 0DX Blackfriars
    London
    Administrateur
    Carmelite
    50 Victoria Embankment
    EC4Y 0DX Blackfriars
    London
    41864110001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    A V Co 3 Limited
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    06 avr. 2016
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 1985
    Lieu d'enregistrementCompanies House, Uk
    Numéro d'enregistrement5851993
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 31 juil. 2006
    Livré le 21 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • European Capital Financial Services Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transactions
    • 21 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral agreement
    Créé le 31 juil. 2006
    Livré le 18 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present and future member of the group (or any of them) to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All capital stock and investment property and all products and proceeds, accessions, stock rights, stock dividends, liquidating dividends, new securities, payments, distributions and proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • European Capital Financial Services Limites as Security Agent for the Finance Parties (The"Security Agent")
    Transactions
    • 18 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over shares
    Créé le 10 déc. 2004
    Livré le 17 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them and to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge all the shares,all related rights.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 17 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 déc. 2004
    Livré le 17 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor to the secured parties or any of them and to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Keyman insurance assignment
    Créé le 09 déc. 2004
    Livré le 17 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them and to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Life assured gerald bowe,sum assured $1,000,000,termination date 27TH september 2048,assurance society protective insurance company,policy number and description life PLO784438 (for further details of life assured see form 395) to assign absolutely its interest in and to the policies and the proceeds and the full benefit thereof as a continuing security to the security trustee.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 17 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 12 sept. 2003
    Livré le 01 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the holdings or any of its subsidiaries to an agent or to any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fleet National Bank
    Transactions
    • 01 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0