H20 NETWORKS LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéH20 NETWORKS LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04896797
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de H20 NETWORKS LTD ?

    • (6420) /
    • (7414) /

    Où se situe H20 NETWORKS LTD ?

    Adresse du siège social
    Central Square 8th Floor
    29 Wellington Square
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de H20 NETWORKS LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour H20 NETWORKS LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    18 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 avr. 2018

    14 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 avr. 2017

    12 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de Benson House 33 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4JP à Central Square 8th Floor 29 Wellington Square Leeds West Yorkshire LS1 4DL le 14 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 avr. 2016

    12 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 avr. 2015

    10 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 avr. 2014

    9 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 avr. 2013

    10 pages4.68

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 03 avr. 2012

    16 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 17 oct. 2011

    12 pages2.24B

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Résultat de la réunion des créanciers

    39 pages2.23B

    Résultat de la réunion des créanciers

    3 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    38 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    8 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de * Manchester Business Park 3000 Aviator Way Manchester M22 5TG United Kingdom* le 16 mai 2011

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Cessation de la nomination de Carl Cumiskey en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * 18 the Parks Newton Le Willows Merseyside WA12 0JQ* le 29 mars 2011

    1 pagesAD01

    legacy

    MG01

    Qui sont les dirigeants de H20 NETWORKS LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FLEMING, David Scott
    67 Moor Lane
    SK9 6BQ Wilmslow
    Cheshire
    Secrétaire
    67 Moor Lane
    SK9 6BQ Wilmslow
    Cheshire
    British51073220001
    COLLINS, Mark Grahame
    Stow Road
    Andoversford
    GL54 5RL Cheltenham
    Chantrys Barn
    Gloucestershire
    Administrateur
    Stow Road
    Andoversford
    GL54 5RL Cheltenham
    Chantrys Barn
    Gloucestershire
    United KingdomBritish148994490001
    MESCH, William Gregory
    Carlton Hill
    St Johns Wood
    NW8 0JX London
    33
    Administrateur
    Carlton Hill
    St Johns Wood
    NW8 0JX London
    33
    EnglandIrish,American141102290001
    SHELTON, Roy Ernest
    29 Wellington Square
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    West Yorkshire
    Administrateur
    29 Wellington Square
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    West Yorkshire
    United KingdomBritish166490670001
    BETHUNE, Iain Charles
    1a Llannerch Road East
    Rhos On Sea
    LL28 4DH Colwyn Bay
    Conwy
    Secrétaire
    1a Llannerch Road East
    Rhos On Sea
    LL28 4DH Colwyn Bay
    Conwy
    British104653490001
    MACKENZIE, Hugh David
    5 Belgrave Road
    CH3 5SA Great Boughton
    Chester
    Secrétaire
    5 Belgrave Road
    CH3 5SA Great Boughton
    Chester
    British51960360001
    COUNTRYWIDE COMPANY SECRETARIES LTD
    386 Palatine Road
    Northenden
    M22 4FZ Manchester
    Secrétaire
    386 Palatine Road
    Northenden
    M22 4FZ Manchester
    89841890001
    HBJGW MANCHESTER SECRETARIES LIMITED
    3 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Secrétaire
    3 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    113594300007
    ANDREWS, Geoffrey Neil
    Lon Cae Glas
    Llanbedr D C
    LL15 1US Ruthin
    Brackendene
    Denbighshire
    Administrateur
    Lon Cae Glas
    Llanbedr D C
    LL15 1US Ruthin
    Brackendene
    Denbighshire
    WalesBritish69349930003
    BETHUNE, William Iain Murdoch
    1a Llannerch Road East
    LL28 4DH Colwyn Bay
    Clwyd
    Administrateur
    1a Llannerch Road East
    LL28 4DH Colwyn Bay
    Clwyd
    United KingdomBritish24342240001
    CHENG, Peter Wai Keung
    176a Nine Mile Ride
    Finchampstead
    RG40 4JB Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    176a Nine Mile Ride
    Finchampstead
    RG40 4JB Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish102826540001
    CUMISKEY, Carl William
    3000 Aviator Way
    M22 5TG Manchester
    Manchester Business Park
    United Kingdom
    Administrateur
    3000 Aviator Way
    M22 5TG Manchester
    Manchester Business Park
    United Kingdom
    United KingdomUk152179190001
    LAWSON, Andrew Stewart
    3 Manor Court
    Marsh Lane, Edleston
    CW5 8GA Nantwich
    Cheshire
    Administrateur
    3 Manor Court
    Marsh Lane, Edleston
    CW5 8GA Nantwich
    Cheshire
    EnglandBritish16370240002
    MACKENZIE, Hugh David
    5 Belgrave Road
    CH3 5SA Great Boughton
    Chester
    Administrateur
    5 Belgrave Road
    CH3 5SA Great Boughton
    Chester
    British51960360001
    SPENCE, David Charles Millar
    High Street
    BA12 0NA Warminster
    The Old School House 11
    Wiltshire
    Administrateur
    High Street
    BA12 0NA Warminster
    The Old School House 11
    Wiltshire
    United KingdomBritish134772200001
    THOMAS, Elfed Wyn
    38 Gloddaeth View
    Penrhyn Bay
    LL30 3FB Llandudno
    Gwynedd
    Administrateur
    38 Gloddaeth View
    Penrhyn Bay
    LL30 3FB Llandudno
    Gwynedd
    WalesBritish45848750002
    THOMAS, Wayne Leslie
    99 Cuerdale Lane
    Walton Le Dale
    PR5 4EP Preston
    Woodnook Lodge
    Lancashire
    Administrateur
    99 Cuerdale Lane
    Walton Le Dale
    PR5 4EP Preston
    Woodnook Lodge
    Lancashire
    EnglandBritish128549760001
    COUNTRYWIDE COMPANY DIRECTORS LTD
    386 Palatine Road
    Northenden
    M22 4FZ Manchester
    Administrateur
    386 Palatine Road
    Northenden
    M22 4FZ Manchester
    89841880001

    H20 NETWORKS LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 22 févr. 2011
    Livré le 03 mars 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • City Fibre Holdings Limited
    Transactions
    • 03 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 28 oct. 2009
    Livré le 04 nov. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon. Barclays bank PLC re H20 networks LTD. Business premium account. Account no:03099857.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Schedule to the master charge agreement
    Créé le 13 sept. 2006
    Livré le 23 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in respect of all equipment which is the subject of customer agreement no SW05/002 (fibre numbers 23/000/01 to 23/000/06 inclusive) (the charged equipment), all proceeds of sale or other disposition of the charged equipment and all insurance monies receivable in respect of damage to or the destruction of loss of any of the charged equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Total Asset Limited
    Transactions
    • 23 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 10 oct. 2005
    Livré le 12 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 12 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    H20 NETWORKS LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 avr. 2012Administration ended
    18 avr. 2011Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David James Kelly
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    practitioner
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Toby Scott Underwood
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    2
    DateType
    03 avr. 2012Commencement of winding up
    17 sept. 2019Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David James Kelly
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    practitioner
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Toby Scott Underwood
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    practitioner
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0