THE JOHN O'GAUNT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE JOHN O'GAUNT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04927662
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE JOHN O'GAUNT LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe THE JOHN O'GAUNT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    55 West Street
    Chichester
    PO19 1RU West Sussex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE JOHN O'GAUNT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CHRYSALIS PUB COMPANY LIMITED21 oct. 200321 oct. 2003
    HH & P THIRTY ONE LIMITED09 oct. 200309 oct. 2003

    Quels sont les derniers comptes de THE JOHN O'GAUNT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour THE JOHN O'GAUNT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    6 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 oct. 2012

    État du capital au 30 oct. 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2011

    5 pagesAA

    Période comptable précédente prolongée du 31 oct. 2010 au 30 avr. 2011

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2009

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher Richard Chesterfield Gordon le 24 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Sally Ann Gordon le 24 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Ams Partnership Ltd en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2008

    4 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2006

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2005

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de THE JOHN O'GAUNT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GORDON, Christopher Richard Chesterfield
    Trentham House 4 Tower Street
    PO10 7BH Emsworth
    Hampshire
    Administrateur
    Trentham House 4 Tower Street
    PO10 7BH Emsworth
    Hampshire
    United KingdomBritishMarketing Director12726190001
    GORDON, Sally Ann
    Trentham House 4 Tower Street
    PO10 7BH Emsworth
    Hampshire
    Administrateur
    Trentham House 4 Tower Street
    PO10 7BH Emsworth
    Hampshire
    United KingdomBritishMarketing Director12731370001
    GROVES, Nicholas Brett
    13 Clover Way
    Hedge End
    SO30 4RN Southampton
    Secrétaire
    13 Clover Way
    Hedge End
    SO30 4RN Southampton
    BritishAccountant108013320001
    WORSLEY, Bridgetta
    9 Haddon Close
    PO14 1PH Fareham
    Hampshire
    Secrétaire
    9 Haddon Close
    PO14 1PH Fareham
    Hampshire
    BritishAccountant38225060002
    AMS PARTNERSHIP LTD
    55 West Street
    PO19 1RU Chichester
    West Sussex
    Secrétaire
    55 West Street
    PO19 1RU Chichester
    West Sussex
    79040730001
    HAARMANN HEMMELRATH SECRETARIES LIMITED
    Floor 25 Tower 42
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Secrétaire
    Floor 25 Tower 42
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    77318700001
    UK COMPANY SECRETARY LTD
    7a The Gardens
    PO16 8SS Fareham
    Hampshire
    Secrétaire
    7a The Gardens
    PO16 8SS Fareham
    Hampshire
    110730280001
    WORSLEY, Bridgetta
    9 Haddon Close
    PO14 1PH Fareham
    Hampshire
    Administrateur
    9 Haddon Close
    PO14 1PH Fareham
    Hampshire
    EnglandBritishAccountant38225060002
    HAARMANN HEMMELRATH SECRETARIES LIMITED
    Floor 25 Tower 42
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Administrateur
    Floor 25 Tower 42
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    77318700001

    THE JOHN O'GAUNT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge of licensed premises
    Créé le 19 août 2004
    Livré le 02 sept. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The john o'gaunt inn horsebridge king somborne stockbridge,by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. The benefit of all justices excise or other licences or registration certificates in connection with the business carried on at the property, the right to recover and receive any compensation payable on account of the non-renewal of such licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge of licensed premises
    Créé le 12 août 2004
    Livré le 31 août 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    White swan public house station road bosham west sussex the benefit of all justices excise or other licences or registration certificates held from time to time in connection with the business carried on at the property and the right to recover and receive any compensation payable at any time on account of the non-renewal of such licences. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge of licensed premises
    Créé le 30 juil. 2004
    Livré le 11 août 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The earl of march public house, lavant, chichester by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. The benefit of all justices excise or other licences or registration certificates held from time to time in connection with the business carried on at the property and the right to recover and receive any compensation payable at any time on account of the non-renewal of such licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 02 juil. 2004
    Livré le 08 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0