ATH GARLEFFAN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéATH GARLEFFAN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04928517
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ATH GARLEFFAN LIMITED ?

    • Exploitation à ciel ouvert de charbon (05102) / Exploitation de mines et carrières

    Où se situe ATH GARLEFFAN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ATH GARLEFFAN LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EVER 2205 LIMITED10 oct. 200310 oct. 2003

    Quels sont les derniers comptes de ATH GARLEFFAN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au02 oct. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ATH GARLEFFAN LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ATH GARLEFFAN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 oct. 2014

    15 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    17 pages4.72

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20

    Changement d'adresse du siège social de Aardvark House, Sidings Court Doncaster South Yorkshire DN4 5NU le 07 août 2013

    2 pagesAD01

    Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2012 au 31 mars 2013

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de David Charles Port en tant que directeur le 05 déc. 2012

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 oct. 2012

    État du capital au 15 oct. 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    17 pagesMG01

    Comptes annuels établis au 02 oct. 2011

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Peter Morgan en tant que directeur le 12 oct. 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James David Wilson en tant que directeur le 12 oct. 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Paul Weatherstone en tant que directeur le 12 oct. 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Paul Weatherstone en tant que secrétaire le 12 oct. 2011

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de John Keith Hodgson en tant que directeur le 12 oct. 2011

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Amendment & restatement agreement 28/09/2011
    RES13

    Comptes annuels établis au 03 oct. 2010

    11 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Charles Port le 01 janv. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur James Wilson le 11 oct. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Charles Port le 11 oct. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Peter Morgan le 11 oct. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Keith Hodgson le 11 oct. 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de ATH GARLEFFAN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WEATHERSTONE, Andrew Paul
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Kpmg Llp
    Leeds
    Secrétaire
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Kpmg Llp
    Leeds
    British86724380003
    BLACK, Alistair
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Kpmg Llp
    Leeds
    Administrateur
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Kpmg Llp
    Leeds
    Great BritainBritish70586070001
    WEATHERSTONE, Andrew Paul
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Kpmg Llp
    Leeds
    Administrateur
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Kpmg Llp
    Leeds
    United KingdomBritish86724380003
    BEAUMONT, Steven
    34 Moorway
    Hawkshaw
    BL8 4LF Bury
    Lancashire
    Secrétaire
    34 Moorway
    Hawkshaw
    BL8 4LF Bury
    Lancashire
    British78820430001
    CROSTON, Richard Andrew
    South Newbald
    YO43 4SU York
    Manor Cottage
    North Yorkshire
    Secrétaire
    South Newbald
    YO43 4SU York
    Manor Cottage
    North Yorkshire
    British132564690001
    WEATHERSTONE, Andrew Paul
    Aardvark House, Sidings Court
    Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    Secrétaire
    Aardvark House, Sidings Court
    Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    British86724380003
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Secrétaire désigné
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023530001
    ALLCHURCH, Thomas John
    Manor House
    Station Road Womersley
    DN6 9BL Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    Manor House
    Station Road Womersley
    DN6 9BL Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish59108210003
    BEAUMONT, Steven
    34 Moorway
    Hawkshaw
    BL8 4LF Bury
    Lancashire
    Administrateur
    34 Moorway
    Hawkshaw
    BL8 4LF Bury
    Lancashire
    United KingdomBritish78820430001
    CROSTON, Richard Andrew
    South Newbald
    YO43 4SU York
    Manor Cottage
    North Yorkshire
    Administrateur
    South Newbald
    YO43 4SU York
    Manor Cottage
    North Yorkshire
    EnglandBritish132564690001
    HODGSON, John Keith
    Aardvark House, Sidings Court
    Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    Administrateur
    Aardvark House, Sidings Court
    Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    Great BritainBritish58649960006
    MORGAN, Peter
    Aardvark House, Sidings Court
    Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    Administrateur
    Aardvark House, Sidings Court
    Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    United KingdomBritish110584610002
    PORT, David Charles
    Aardvark House, Sidings Court
    Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    Administrateur
    Aardvark House, Sidings Court
    Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    United KingdomBritish58053990001
    TOD, Michael Thomas Winton
    Newton Place
    Marton Road, Willingham By Stow
    DN21 5JU Gainsborough
    Lincolnshire
    Administrateur
    Newton Place
    Marton Road, Willingham By Stow
    DN21 5JU Gainsborough
    Lincolnshire
    United KingdomBritish81015120002
    WEATHERSTONE, Andrew Paul
    Aardvark House, Sidings Court
    Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    Administrateur
    Aardvark House, Sidings Court
    Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    United KingdomBritish86724380003
    WILSON, James David
    Aardvark House, Sidings Court
    Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    Administrateur
    Aardvark House, Sidings Court
    Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    United KingdomBritish108745290002
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Administrateur désigné
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023520001

    ATH GARLEFFAN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 29 févr. 2012
    Livré le 09 mars 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Euler Hermes UK,UK Branch (The "Security Agent")
    Transactions
    • 09 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 02 nov. 2009
    Livré le 04 nov. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to the secured finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    For details of properties charged, please refer to form 395, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Agent
    Transactions
    • 04 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 09 janv. 2006
    Livré le 19 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 04 december 2003 and
    Créé le 28 nov. 2003
    Livré le 19 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the subjects being part of high polquheys farm polquheys road cumnock KA18 4NX containing the access road to garleffan open cast coal site and other land t/n AYR35031. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alchemy Partners Nominees Limited
    Transactions
    • 19 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 04 december 2003 and
    Créé le 28 nov. 2003
    Livré le 19 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the subjects k/a heatherview cottage new cumnock t/n AYR37885. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alchemy Partners Nominees Limited
    Transactions
    • 19 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 04 december 2003 and
    Créé le 28 nov. 2003
    Livré le 19 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole those three plots or areas of ground extending in total to fifty six thousand seven hundred and seven square metres or thereby k/a cowbandsgate rail terminal new cumnock t/n AYR54182. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alchemy Partners Nominees Limited
    Transactions
    • 19 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 04/12/03 and
    Créé le 28 nov. 2003
    Livré le 22 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Heatherview cottage, new cumnock t/n AYR37885.
    Personnes ayant droit
    • Law Mining Limited
    Transactions
    • 22 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 04/12/03 and
    Créé le 28 nov. 2003
    Livré le 22 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Those three plots or areas of ground extending in total to 506,707 thereby known as crowbandsgate rail terminal, new cumnock t/n ayr 54182.
    Personnes ayant droit
    • Law Mining Limited
    Transactions
    • 22 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 04/12/03 and
    Créé le 28 nov. 2003
    Livré le 22 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Part of high polquheys farm, polquheys road, cumnock KA18 4NX containing the access road to garleffan opencast coal site t/n ayr 35031.
    Personnes ayant droit
    • Law Mining Limited
    Transactions
    • 22 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 nov. 2003
    Livré le 16 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alchemy Partners Nominees Limited
    Transactions
    • 16 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 nov. 2003
    Livré le 06 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 28 nov. 2003
    Livré le 06 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property (including uncalled capital) which is or may be from time to time comprised in the property and undertaking.
    Personnes ayant droit
    • Terex UK Limited
    Transactions
    • 06 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 nov. 2003
    Livré le 04 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All future f/h and l/h property beloning to the company together with all buildings, fixtures, plant and machinery, all present and future interests of the company in or over land or the proceeds of sale of it, all goodwill and uncalled capital and all other assets.
    Personnes ayant droit
    • Law Mining Limited
    Transactions
    • 04 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ATH GARLEFFAN LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 août 2013Commencement of winding up
    11 févr. 2015Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    practitioner
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    practitioner
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0