PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED

PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPREFERRED FUNDING FIVE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04930708
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hays Galleria
    1 Hays Lane
    SE1 2RD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PINKCLOSE LIMITED14 oct. 200314 oct. 2003

    Quels sont les derniers comptes de PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 sept. 2018

    7 pagesLIQ03

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 04 sept. 2017

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Déclaration de confirmation établie le 27 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 10-18 Union Street London SE1 1SZ United Kingdom à Hays Galleria 1 Hays Lane London SE1 2rd le 13 avr. 2017

    2 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    5 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    5 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    6 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    6 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2015

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2016

    État du capital au 15 juin 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de Level 23 25 Canada Square London E14 5LQ à 10-18 Union Street London SE1 1SZ le 22 janv. 2016

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2014

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2015

    État du capital au 15 juin 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2013

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 juin 2014

    État du capital au 03 juin 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2012

    16 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    11 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Other company business 08/03/2013
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2011

    16 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRANDON, Lee Christopher
    1 Hays Lane
    SE1 2RD London
    Hays Galleria
    Administrateur
    1 Hays Lane
    SE1 2RD London
    Hays Galleria
    United KingdomBritish152212570001
    HOPES, Philip Edward
    Ellensdaw
    Polecat Lane
    RH13 6QR Copsale
    West Sussex
    Secrétaire
    Ellensdaw
    Polecat Lane
    RH13 6QR Copsale
    West Sussex
    British59370220003
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES (CCA) LIMITED
    Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    10
    Secrétaire
    Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    10
    83911920002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    1st Floor, 9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    England
    Secrétaire
    1st Floor, 9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement06902863
    140723560001
    ATTIA, Amany
    Girdlers Road
    W13 0PU London
    8
    Administrateur
    Girdlers Road
    W13 0PU London
    8
    United KingdomFrench - American94699620002
    ATTIA, Amany
    The Old House
    W6 7BD 101 Brook Green
    London
    Administrateur
    The Old House
    W6 7BD 101 Brook Green
    London
    French American94699620001
    BILSBOROUGH, William C
    Tresanton
    Hancocks Mount
    SL5 9PQ Sunninghill
    Berkshire
    Administrateur
    Tresanton
    Hancocks Mount
    SL5 9PQ Sunninghill
    Berkshire
    Us Citizen107220450001
    CHAMBERS, Paul Stuart
    Burntwood Road
    TN13 1PT Sevenoaks
    10
    Kent
    Administrateur
    Burntwood Road
    TN13 1PT Sevenoaks
    10
    Kent
    United KingdomBritish172496620001
    FRASER, George Mclennan
    57 Chipstead Street
    SW6 3SR London
    Administrateur
    57 Chipstead Street
    SW6 3SR London
    Australian94699810001
    GIBB, Dominic Iain
    2 Falkland Place
    NW5 2PN London
    Administrateur
    2 Falkland Place
    NW5 2PN London
    British62250460004
    HINSHELWOOD, Wallace Simon Duthie
    11 Wheelwrights Close
    CM23 4GH Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    11 Wheelwrights Close
    CM23 4GH Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish91642420002
    HOPES, Philip Edward
    Ellensdaw
    Polecat Lane
    RH13 6QR Copsale
    West Sussex
    Administrateur
    Ellensdaw
    Polecat Lane
    RH13 6QR Copsale
    West Sussex
    British59370220003
    INGRAM, Nigel Jeffrey Martin
    Meadowlands
    Winterpit Lane
    RH13 6LZ Mannings Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Meadowlands
    Winterpit Lane
    RH13 6LZ Mannings Heath
    West Sussex
    United KingdomBritish97379760001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Administrateur désigné
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MEHR, Amir
    Hartwell Drive
    HP9 1JA Beaconsfield
    5
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Hartwell Drive
    HP9 1JA Beaconsfield
    5
    Buckinghamshire
    United KingdomAmerican130034860001
    PATELLIS, George
    The Gatehouse
    20 Kings Gate
    RH16 1DY Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    The Gatehouse
    20 Kings Gate
    RH16 1DY Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomAmerican76275030002
    PITOCCO, Dennis James
    The Annexe Cedar Lodge
    6 Calbourne
    RH16 4AQ Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    The Annexe Cedar Lodge
    6 Calbourne
    RH16 4AQ Haywards Heath
    West Sussex
    American59515170003
    PUDGE, David John
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Administrateur
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    United KingdomBritish162620820001
    RUPP, Christopher Gordon
    Revelmead
    Hillside Road
    TN13 3XJ Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Revelmead
    Hillside Road
    TN13 3XJ Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish72545640001
    STAID, Stephen
    1 Ridgeway
    GU25 4TE Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    1 Ridgeway
    GU25 4TE Virginia Water
    Surrey
    United KingdomAmerican125380160001
    TAYLOR, Roger John
    Rare Oak
    Highfield Gardens
    GU33 7NQ Liss
    Hampshire
    Administrateur
    Rare Oak
    Highfield Gardens
    GU33 7NQ Liss
    Hampshire
    British68131560002
    WEIR, Louise Jane
    Tunnel Lane
    North Warnborough
    RG29 1JT Hook
    Heron House
    Hants
    Administrateur
    Tunnel Lane
    North Warnborough
    RG29 1JT Hook
    Heron House
    Hants
    EnglandBritish130033570001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    1 Hays Lane
    SE1 2RD London
    Hays Galleria
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    1 Hays Lane
    SE1 2RD London
    Hays Galleria
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleUnited Kingdom (Uk)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03137809
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A warehouse deed of charge
    Créé le 09 nov. 2005
    Livré le 28 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower or the guarantor to any or all of the secured parties or their respective affilliates or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title interest and benefit present and future in the secur ity assets the benefit of the collateral security. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Storm Funding Limited
    Transactions
    • 28 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mai 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 30 mai 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 03 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    An amended and restated deed relating to a warehouse deed of charge dated 27 july 2005 and
    Créé le 09 nov. 2005
    Livré le 23 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to any or all of the secured parties or their respective affiliates or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title interest and benefit, present and future, in the security assets, the benefit of the collateral security. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Storm Funding Limited (Holding the Benefit of the Security on Trust for the Secured Parties,Including Itself)
    Transactions
    • 23 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignation in security
    Créé le 25 oct. 2005
    Livré le 27 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to any or all of the secured parties or their respective affiliates or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company's whole right title and interest in and to the scottish mortgage trust property and in and to the scottish declaration of trust.
    Personnes ayant droit
    • Storm Funding Limited Acting as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transactions
    • 27 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A warehouse deed of charge
    Créé le 25 oct. 2005
    Livré le 26 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to any or all of the secured parties or their respective affiliates or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right, title, interest and benefit, present and future in the security assets the benefit of the collateral security. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Storm Funding Limited Acting as Security Truatee for the Benefit of the Secured Parties
    Transactions
    • 26 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2006Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 06 août 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 31 janv. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 31 janv. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 30 mai 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 30 mai 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 03 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental assignation in security
    Créé le 28 juil. 2005
    Livré le 17 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to any of all of the secured parties or to any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All principal sums and further advances all of scotish mortgage loans. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Storm Funding Limited (The Secutrity Trustee)
    Transactions
    • 17 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A warehouse deed of charge
    Créé le 27 juil. 2005
    Livré le 16 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to any or all of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all its right title interest and benefit in the security assets including the english mortgage loans and northern irish mortgage loans, the right to demand sue for recover receive and give receipts for all principal moneys payable or to become payable under the english mortgage loans or the northern irish mortgage loans. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Storm Funding Limited (Holding the Benefit of the Security on Trust for the Secured Parties)
    Transactions
    • 16 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2006Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 16 janv. 2006Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 30 mai 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 30 mai 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 03 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignation in security
    Créé le 18 nov. 2003
    Livré le 03 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or preferred mortgages limited to any or all of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The whole right, title and interest, present and future, in and to the scottish mortgage trust property and in and to the scottish declaration of trust.
    Personnes ayant droit
    • Mable Commercial Funding Limited in Its Capacity as Security Trustee
    Transactions
    • 03 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Warehouse deed of charge
    Créé le 05 nov. 2003
    Livré le 14 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to any or all of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all its right title interest and benefit in the security assets including the english mortgage loans and northern irish mortgage loans, the right to demand sue for recover receive and give receipts for all principal moneys payable or to become payable under the english mortgage loans or the northern irish mortgage loans. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mable Commercial Funding Limited as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transactions
    • 14 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 sept. 2017Commencement of winding up
    08 févr. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0