PATHVALLEY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPATHVALLEY LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04946344
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PATHVALLEY LIMITED ?

    • Pharmacie en officine (47730) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe PATHVALLEY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Lynstock House
    Lynstock Way Lostock
    BL6 4SA Bolton
    Greater Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PATHVALLEY LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 août 2024
    Date d'échéance des prochains comptes31 mai 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PATHVALLEY LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au30 avr. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 mai 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au30 avr. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour PATHVALLEY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XD319VBK

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2023

    2 pagesAA
    XCYG9NBM

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XC3LRT0X

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2022

    2 pagesAA
    XBWFJZEZ

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2021

    2 pagesAA
    XB4SF95T

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XB3TEHDU

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XA3XB67Z

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2020

    2 pagesAA
    XA3XB4GQ

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X951LAZ7

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2019

    2 pagesAA
    X94JBWS0

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X85DVO95

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2018

    2 pagesAA
    X7ISTQYY

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2017

    2 pagesAA
    X74ZDS61

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X74ZB15K

    Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X7228BYZ

    Déclaration de confirmation établie le 20 mars 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01
    X653K30Q

    Comptes annuels établis au 31 août 2016

    16 pagesAA
    A62WR5NL

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    2 pagesMR04
    X62EH9O3

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04
    X62EH9GQ

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    2 pagesMR04
    X62EH9OR

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    2 pagesMR04
    X62EHA4P

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    2 pagesMR04
    X62EHAI3

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    2 pagesMR04
    X62EHACQ

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04
    A60U2R2G

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 mars 2016

    État du capital au 23 mars 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01
    X53D5ATD

    Qui sont les dirigeants de PATHVALLEY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAUNCE, Andrew John
    Lynstock House
    Lynstock Way Lostock
    BL6 4SA Bolton
    Greater Manchester
    Administrateur
    Lynstock House
    Lynstock Way Lostock
    BL6 4SA Bolton
    Greater Manchester
    EnglandBritishAccountant165879390001
    GORGEMEAD LIMITED
    Lynstock Way
    Lostock
    BL6 4SA Bolton
    Lynstock House
    England
    Administrateur
    Lynstock Way
    Lostock
    BL6 4SA Bolton
    Lynstock House
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement01425062
    106507080001
    PATEL, Anwer Ibrahim Issa Ismail
    4 Breckland Drive
    Heaton
    BL1 5BQ Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    4 Breckland Drive
    Heaton
    BL1 5BQ Bolton
    Lancashire
    BritishDirector98227610001
    WILD, Steven
    59a Schools Hill Road
    SK8 1JE Cheadle
    Cheshire
    Secrétaire
    59a Schools Hill Road
    SK8 1JE Cheadle
    Cheshire
    BritishAccountant42377710001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    Secrétaire désigné
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    900027310001
    CHOTHANI, Devshi
    315 Frederick Street
    OL8 4HG Oldham
    Administrateur
    315 Frederick Street
    OL8 4HG Oldham
    EnglandBritishChartered Accountant29902780002
    FISHWICK, Craig Bernard
    Lynstock House
    Lynstock Way Lostock
    BL6 4SA Bolton
    Greater Manchester
    Administrateur
    Lynstock House
    Lynstock Way Lostock
    BL6 4SA Bolton
    Greater Manchester
    EnglandBritishDirector164196160001
    HALL, Stephen David
    Lynstock House
    Lynstock Way Lostock
    BL6 4SA Bolton
    Greater Manchester
    Administrateur
    Lynstock House
    Lynstock Way Lostock
    BL6 4SA Bolton
    Greater Manchester
    EnglandBritishDirector157481410001
    PATEL, Anwer Ibrahim Issa Ismail
    4 Breckland Drive
    Heaton
    BL1 5BQ Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    4 Breckland Drive
    Heaton
    BL1 5BQ Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishDirector98227610001
    PATEL, Yakub Ibrahim
    11 Northwold Drive
    BL1 5BH Bolton
    Greater Manchester
    Administrateur
    11 Northwold Drive
    BL1 5BH Bolton
    Greater Manchester
    EnglandBritishDirector47737270002
    RICE, Karen Elizabeth
    Lynstock House
    Lynstock Way Lostock
    BL6 4SA Bolton
    Greater Manchester
    Administrateur
    Lynstock House
    Lynstock Way Lostock
    BL6 4SA Bolton
    Greater Manchester
    EnglandBritishPharmacist136291920001
    SERRANT, Zoe
    Lynstock House
    Lynstock Way Lostock
    BL6 4SA Bolton
    Greater Manchester
    Administrateur
    Lynstock House
    Lynstock Way Lostock
    BL6 4SA Bolton
    Greater Manchester
    EnglandBritishPharmacist166039030001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    Administrateur désigné
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    900027300001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PATHVALLEY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Anwer Ibrahim Issa Ismail Patel
    Lynstock House
    Lynstock Way Lostock
    BL6 4SA Bolton
    Greater Manchester
    06 avr. 2016
    Lynstock House
    Lynstock Way Lostock
    BL6 4SA Bolton
    Greater Manchester
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Mr Yakub Ibrahim Patel
    Lynstock House
    Lynstock Way Lostock
    BL6 4SA Bolton
    Greater Manchester
    06 avr. 2016
    Lynstock House
    Lynstock Way Lostock
    BL6 4SA Bolton
    Greater Manchester
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.

    PATHVALLEY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge of securities (UK)
    Créé le 05 févr. 2010
    Livré le 17 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge any stocks shares bonds or warrants or securities (certificated or uncertificated) which are from time to time named in any schedule supplied by or on behalf of the company to the bank by reference to the charge of securities or in respect of which title or the relevant account entries is/are held in the name of or to the order of the bank or its nominee or in respect of which the relevant certificates or other title documents are deposited with or held to the order of the bank or its nominee together with all income derived from and rights attaching to the same.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 17 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of deposit
    Créé le 13 oct. 2009
    Livré le 28 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £7,300 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Interest in the deposit account and all money from time to time withdrawn from the deposit account see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fiona Jane Foss
    Transactions
    • 28 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 22 févr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed & floating charge
    Créé le 10 mars 2009
    Livré le 12 mars 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited (The Security Holder)
    Transactions
    • 12 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 25 janv. 2005
    Livré le 04 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that the premises k/a 97 market street chorley lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 25 janv. 2005
    Livré le 28 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Premises k/a 27 derby street atherton manchester comprised in and demised by a lease dated 24/12/92 between the wigan borough council. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 14 janv. 2005
    Livré le 20 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    22 swan street, manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 01 avr. 2004
    Livré le 21 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    285 bradford road frizinghall shipley,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 02 févr. 2004
    Livré le 05 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property being 84 kings road sedgley park prestwich manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 20 janv. 2004
    Livré le 22 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0