THE WHITELEY HOMES TRUST

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE WHITELEY HOMES TRUST
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société 04957706
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE WHITELEY HOMES TRUST ?

    • Autres hébergements (55900) / Hébergement et restauration

    Où se situe THE WHITELEY HOMES TRUST ?

    Adresse du siège social
    Huntley House Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Surrey
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de THE WHITELEY HOMES TRUST ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE WHITELEY HOMES TRUST ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au10 nov. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation24 nov. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au10 nov. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour THE WHITELEY HOMES TRUST ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Mr Reginald David Philip Bek en tant qu'administrateur le 16 déc. 2025

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 10 nov. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Alison Halliday Kennedy en tant que directeur le 05 juin 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robbie Lewis Young en tant que directeur le 02 oct. 2025

    1 pagesTM01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2024

    62 pagesAA

    Nomination de Mr David Jenkins en tant qu'administrateur le 26 mars 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Fiona Mcanena en tant que directeur le 11 avr. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Joanna Kate Beauchamp en tant que directeur le 26 mars 2025

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Jaswant Rai Joshi en tant qu'administrateur le 18 déc. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Rodney John Bennion en tant que directeur le 31 janv. 2025

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Elizabeth Anne Hauxwell en tant qu'administrateur le 18 déc. 2024

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 10 nov. 2024 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2023

    62 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Eliza Palmer Care Hub Whiteley Village Octagon Road Walton on Thames Surrey KT12 4ES England à Huntley House Octagon Road Whiteley Village Walton on Thames Surrey KT12 4BF le 29 juil. 2024

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Sanjay Gulati en tant qu'administrateur le 26 juin 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Keith John Hiscock en tant que directeur le 12 déc. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Beverly Ann Castleton en tant que directeur le 26 juin 2024

    1 pagesTM01

    Divers

    HC01 notification of registration of a company as a registered provider of social housing
    2 pagesMISC

    Déclaration de confirmation établie le 10 nov. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Craig Bryant en tant qu'administrateur le 02 oct. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Nathan Michael Rees en tant qu'administrateur le 02 oct. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Julienne Elizabeth Meyer en tant que directeur le 12 sept. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2022

    64 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Statuts

    16 pagesMA

    Qui sont les dirigeants de THE WHITELEY HOMES TRUST ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BEK, Reginald David Philip
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    Administrateur
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    United KingdomBritish345949280001
    BRYANT, Craig
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    Administrateur
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    United KingdomBritish314703340001
    GULATI, Sanjay
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    Administrateur
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    EnglandBritish160661980001
    HAUXWELL, Elizabeth Anne
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    Administrateur
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    EnglandBritish167630670002
    HENDERSON, Mark Gideon
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    Administrateur
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    United KingdomBritish81681820003
    JENKINS, David
    Ferndale Avenue
    KT16 9RB Chertsey
    26
    England
    Administrateur
    Ferndale Avenue
    KT16 9RB Chertsey
    26
    England
    EnglandBritish335215560001
    JOSHI, Jaswant Rai
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    Administrateur
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    EnglandBritish332967290001
    LINDSAY, Melanie
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    Administrateur
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    EnglandBritish91625700001
    REES, Nathan Michael
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    Administrateur
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    United KingdomBritish198450200001
    ROYCROFT, Michael John, Brigadier
    Fox Oak Cottage
    West Avenue, Whiteley Village
    KT12 4DQ Walton On Thames
    Surrey
    Secrétaire
    Fox Oak Cottage
    West Avenue, Whiteley Village
    KT12 4DQ Walton On Thames
    Surrey
    British98675080002
    WARD, Anthony Clark, Colonel
    Fox Oak Cottage
    Seven Hills Road
    KT12 4DG Walton On Thames
    Surrey
    Secrétaire
    Fox Oak Cottage
    Seven Hills Road
    KT12 4DG Walton On Thames
    Surrey
    British79355340001
    ANGELL, Ian Hugh Arthur
    7 Carlton Road
    KT3 3AJ New Malden
    Surrey
    Administrateur
    7 Carlton Road
    KT3 3AJ New Malden
    Surrey
    United KingdomBritish2309690001
    BARDWELL, Colin William
    South Dean
    Dippenhall Street, Crondall
    GU10 5NY Farnham
    Surrey
    Administrateur
    South Dean
    Dippenhall Street, Crondall
    GU10 5NY Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish80577290001
    BARRETT, Melbourne Junior
    Whiteley Village
    Octagon Road
    KT12 4ES Walton On Thames
    Eliza Palmer Care Hub
    Surrey
    England
    Administrateur
    Whiteley Village
    Octagon Road
    KT12 4ES Walton On Thames
    Eliza Palmer Care Hub
    Surrey
    England
    EnglandBritish133747280001
    BEAUCHAMP, Joanna Kate
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    Administrateur
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    EnglandBritish187275220001
    BENNION, Rodney John
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    Administrateur
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    EnglandBritish13574910002
    BERRY, Michael David
    Whiteley Village
    Octagon Road
    KT12 4ES Walton On Thames
    Eliza Palmer Care Hub
    Surrey
    England
    Administrateur
    Whiteley Village
    Octagon Road
    KT12 4ES Walton On Thames
    Eliza Palmer Care Hub
    Surrey
    England
    EnglandBritish259845780001
    BIDDELL, Christopher William
    Hampton Lodge
    Seale
    GU10 1JF Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Hampton Lodge
    Seale
    GU10 1JF Farnham
    Surrey
    EnglandBritish79355380001
    BRITTON, Mark Gordon, Dr
    Whiteley Village
    Octagon Road
    KT12 4ES Walton On Thames
    Eliza Palmer Care Hub
    Surrey
    England
    Administrateur
    Whiteley Village
    Octagon Road
    KT12 4ES Walton On Thames
    Eliza Palmer Care Hub
    Surrey
    England
    EnglandBritish56943380001
    BURGESS, Jean Angelique Leslie, Lady
    Home Close
    Grayswood
    GU27 2DE Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    Home Close
    Grayswood
    GU27 2DE Haslemere
    Surrey
    British93704100001
    BUTCHER, Tessa Nelia, Dr
    4 Toronto Drive
    Smallfield
    RH6 9RB Surrey
    Administrateur
    4 Toronto Drive
    Smallfield
    RH6 9RB Surrey
    British93704090001
    CASTLETON, Beverly Ann, Dr
    Whiteley Village
    Octagon Road
    KT12 4ES Walton On Thames
    Eliza Palmer Care Hub
    Surrey
    England
    Administrateur
    Whiteley Village
    Octagon Road
    KT12 4ES Walton On Thames
    Eliza Palmer Care Hub
    Surrey
    England
    EnglandBritish195090370001
    COWLEY, Dean Crispin
    Octagon Road, Whiteley Village
    Walton-On-Thames
    KT12 4EH Surrey
    Administrateur
    Octagon Road, Whiteley Village
    Walton-On-Thames
    KT12 4EH Surrey
    EnglandEnglish168357060001
    ELDER, Ian Francis
    Octagon Road, Whiteley Village
    Walton-On-Thames
    KT12 4EH Surrey
    Administrateur
    Octagon Road, Whiteley Village
    Walton-On-Thames
    KT12 4EH Surrey
    EnglandBritish111854110002
    FARRER, Johanna Creszentia Maria Dorothea, Lady
    6 Priory Avenue
    W4 1TX London
    Administrateur
    6 Priory Avenue
    W4 1TX London
    EnglandBritish114711200001
    FORMBY, Roger Myles
    Church Gate House
    47 Church Walk
    KT7 0NN Thames Ditton
    Surrey
    Administrateur
    Church Gate House
    47 Church Walk
    KT7 0NN Thames Ditton
    Surrey
    EnglandBritish3641860001
    HAIN, Keturah
    Crow Gables
    Fairmile Lane
    KT11 2BU Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Crow Gables
    Fairmile Lane
    KT11 2BU Cobham
    Surrey
    British93704080001
    HANWORTH, Rosamond, The Rt Hon Viscountess
    Quoin Cottage
    Shamley Green
    GU5 0UJ Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Quoin Cottage
    Shamley Green
    GU5 0UJ Guildford
    Surrey
    British93704070001
    HISCOCK, Keith John
    Whiteley Village
    Octagon Road
    KT12 4ES Walton On Thames
    Eliza Palmer Care Hub
    Surrey
    England
    Administrateur
    Whiteley Village
    Octagon Road
    KT12 4ES Walton On Thames
    Eliza Palmer Care Hub
    Surrey
    England
    EnglandBritish172915150001
    HOSKIN, Thomas David
    Whiteley Village
    Octagon Road
    KT12 4ES Walton On Thames
    Eliza Palmer Care Hub
    Surrey
    England
    Administrateur
    Whiteley Village
    Octagon Road
    KT12 4ES Walton On Thames
    Eliza Palmer Care Hub
    Surrey
    England
    EnglandBritish259846310001
    JOY, Caroline Mary
    Marelands
    Bentley
    GU10 5JB Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Marelands
    Bentley
    GU10 5JB Farnham
    Surrey
    British93704060001
    KAVI, Dilip
    Whiteley Village
    Octagon Road
    KT12 4ES Walton On Thames
    Eliza Palmer Care Hub
    Surrey
    England
    Administrateur
    Whiteley Village
    Octagon Road
    KT12 4ES Walton On Thames
    Eliza Palmer Care Hub
    Surrey
    England
    United KingdomBritish168418840001
    KENNEDY, Alison Halliday
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    Administrateur
    Octagon Road
    Whiteley Village
    KT12 4BF Walton On Thames
    Huntley House
    Surrey
    England
    EnglandBritish277717720001
    LAMEY, John Keith
    Whiteley Village
    Octagon Road
    KT12 4ES Walton On Thames
    Eliza Palmer Care Hub
    Surrey
    England
    Administrateur
    Whiteley Village
    Octagon Road
    KT12 4ES Walton On Thames
    Eliza Palmer Care Hub
    Surrey
    England
    EnglandBritish13431090001
    LLEWELYN, Julie Anne, Dr
    Hydon End
    Feathercombe Lane, Hambledon
    GU8 4DP Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Hydon End
    Feathercombe Lane, Hambledon
    GU8 4DP Godalming
    Surrey
    United KingdomBritish108215350002

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE WHITELEY HOMES TRUST ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    10 nov. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0