THE WHITELEY HOMES TRUST
Vue d'ensemble
| Nom de la société | THE WHITELEY HOMES TRUST |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
| Numéro de société | 04957706 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE WHITELEY HOMES TRUST ?
| Adresse du siège social | Huntley House Octagon Road Whiteley Village KT12 4BF Walton On Thames Surrey England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE WHITELEY HOMES TRUST ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE WHITELEY HOMES TRUST ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 10 nov. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 24 nov. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 10 nov. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour THE WHITELEY HOMES TRUST ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomination de Mr Reginald David Philip Bek en tant qu'administrateur le 16 déc. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 nov. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alison Halliday Kennedy en tant que directeur le 05 juin 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robbie Lewis Young en tant que directeur le 02 oct. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2024 | 62 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr David Jenkins en tant qu'administrateur le 26 mars 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Fiona Mcanena en tant que directeur le 11 avr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Joanna Kate Beauchamp en tant que directeur le 26 mars 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Jaswant Rai Joshi en tant qu'administrateur le 18 déc. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rodney John Bennion en tant que directeur le 31 janv. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Elizabeth Anne Hauxwell en tant qu'administrateur le 18 déc. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 nov. 2024 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2023 | 62 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Eliza Palmer Care Hub Whiteley Village Octagon Road Walton on Thames Surrey KT12 4ES England à Huntley House Octagon Road Whiteley Village Walton on Thames Surrey KT12 4BF le 29 juil. 2024 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr Sanjay Gulati en tant qu'administrateur le 26 juin 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Keith John Hiscock en tant que directeur le 12 déc. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Beverly Ann Castleton en tant que directeur le 26 juin 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Divers HC01 notification of registration of a company as a registered provider of social housing | 2 pages | MISC | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 nov. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Craig Bryant en tant qu'administrateur le 02 oct. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Nathan Michael Rees en tant qu'administrateur le 02 oct. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Julienne Elizabeth Meyer en tant que directeur le 12 sept. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2022 | 64 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Statuts | 16 pages | MA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de THE WHITELEY HOMES TRUST ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEK, Reginald David Philip | Administrateur | Octagon Road Whiteley Village KT12 4BF Walton On Thames Huntley House Surrey England | United Kingdom | British | 345949280001 | |||||
| BRYANT, Craig | Administrateur | Octagon Road Whiteley Village KT12 4BF Walton On Thames Huntley House Surrey England | United Kingdom | British | 314703340001 | |||||
| GULATI, Sanjay | Administrateur | Octagon Road Whiteley Village KT12 4BF Walton On Thames Huntley House Surrey England | England | British | 160661980001 | |||||
| HAUXWELL, Elizabeth Anne | Administrateur | Octagon Road Whiteley Village KT12 4BF Walton On Thames Huntley House Surrey England | England | British | 167630670002 | |||||
| HENDERSON, Mark Gideon | Administrateur | Octagon Road Whiteley Village KT12 4BF Walton On Thames Huntley House Surrey England | United Kingdom | British | 81681820003 | |||||
| JENKINS, David | Administrateur | Ferndale Avenue KT16 9RB Chertsey 26 England | England | British | 335215560001 | |||||
| JOSHI, Jaswant Rai | Administrateur | Octagon Road Whiteley Village KT12 4BF Walton On Thames Huntley House Surrey England | England | British | 332967290001 | |||||
| LINDSAY, Melanie | Administrateur | Octagon Road Whiteley Village KT12 4BF Walton On Thames Huntley House Surrey England | England | British | 91625700001 | |||||
| REES, Nathan Michael | Administrateur | Octagon Road Whiteley Village KT12 4BF Walton On Thames Huntley House Surrey England | United Kingdom | British | 198450200001 | |||||
| ROYCROFT, Michael John, Brigadier | Secrétaire | Fox Oak Cottage West Avenue, Whiteley Village KT12 4DQ Walton On Thames Surrey | British | 98675080002 | ||||||
| WARD, Anthony Clark, Colonel | Secrétaire | Fox Oak Cottage Seven Hills Road KT12 4DG Walton On Thames Surrey | British | 79355340001 | ||||||
| ANGELL, Ian Hugh Arthur | Administrateur | 7 Carlton Road KT3 3AJ New Malden Surrey | United Kingdom | British | 2309690001 | |||||
| BARDWELL, Colin William | Administrateur | South Dean Dippenhall Street, Crondall GU10 5NY Farnham Surrey | United Kingdom | British | 80577290001 | |||||
| BARRETT, Melbourne Junior | Administrateur | Whiteley Village Octagon Road KT12 4ES Walton On Thames Eliza Palmer Care Hub Surrey England | England | British | 133747280001 | |||||
| BEAUCHAMP, Joanna Kate | Administrateur | Octagon Road Whiteley Village KT12 4BF Walton On Thames Huntley House Surrey England | England | British | 187275220001 | |||||
| BENNION, Rodney John | Administrateur | Octagon Road Whiteley Village KT12 4BF Walton On Thames Huntley House Surrey England | England | British | 13574910002 | |||||
| BERRY, Michael David | Administrateur | Whiteley Village Octagon Road KT12 4ES Walton On Thames Eliza Palmer Care Hub Surrey England | England | British | 259845780001 | |||||
| BIDDELL, Christopher William | Administrateur | Hampton Lodge Seale GU10 1JF Farnham Surrey | England | British | 79355380001 | |||||
| BRITTON, Mark Gordon, Dr | Administrateur | Whiteley Village Octagon Road KT12 4ES Walton On Thames Eliza Palmer Care Hub Surrey England | England | British | 56943380001 | |||||
| BURGESS, Jean Angelique Leslie, Lady | Administrateur | Home Close Grayswood GU27 2DE Haslemere Surrey | British | 93704100001 | ||||||
| BUTCHER, Tessa Nelia, Dr | Administrateur | 4 Toronto Drive Smallfield RH6 9RB Surrey | British | 93704090001 | ||||||
| CASTLETON, Beverly Ann, Dr | Administrateur | Whiteley Village Octagon Road KT12 4ES Walton On Thames Eliza Palmer Care Hub Surrey England | England | British | 195090370001 | |||||
| COWLEY, Dean Crispin | Administrateur | Octagon Road, Whiteley Village Walton-On-Thames KT12 4EH Surrey | England | English | 168357060001 | |||||
| ELDER, Ian Francis | Administrateur | Octagon Road, Whiteley Village Walton-On-Thames KT12 4EH Surrey | England | British | 111854110002 | |||||
| FARRER, Johanna Creszentia Maria Dorothea, Lady | Administrateur | 6 Priory Avenue W4 1TX London | England | British | 114711200001 | |||||
| FORMBY, Roger Myles | Administrateur | Church Gate House 47 Church Walk KT7 0NN Thames Ditton Surrey | England | British | 3641860001 | |||||
| HAIN, Keturah | Administrateur | Crow Gables Fairmile Lane KT11 2BU Cobham Surrey | British | 93704080001 | ||||||
| HANWORTH, Rosamond, The Rt Hon Viscountess | Administrateur | Quoin Cottage Shamley Green GU5 0UJ Guildford Surrey | British | 93704070001 | ||||||
| HISCOCK, Keith John | Administrateur | Whiteley Village Octagon Road KT12 4ES Walton On Thames Eliza Palmer Care Hub Surrey England | England | British | 172915150001 | |||||
| HOSKIN, Thomas David | Administrateur | Whiteley Village Octagon Road KT12 4ES Walton On Thames Eliza Palmer Care Hub Surrey England | England | British | 259846310001 | |||||
| JOY, Caroline Mary | Administrateur | Marelands Bentley GU10 5JB Farnham Surrey | British | 93704060001 | ||||||
| KAVI, Dilip | Administrateur | Whiteley Village Octagon Road KT12 4ES Walton On Thames Eliza Palmer Care Hub Surrey England | United Kingdom | British | 168418840001 | |||||
| KENNEDY, Alison Halliday | Administrateur | Octagon Road Whiteley Village KT12 4BF Walton On Thames Huntley House Surrey England | England | British | 277717720001 | |||||
| LAMEY, John Keith | Administrateur | Whiteley Village Octagon Road KT12 4ES Walton On Thames Eliza Palmer Care Hub Surrey England | England | British | 13431090001 | |||||
| LLEWELYN, Julie Anne, Dr | Administrateur | Hydon End Feathercombe Lane, Hambledon GU8 4DP Godalming Surrey | United Kingdom | British | 108215350002 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE WHITELEY HOMES TRUST ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 10 nov. 2016 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0