BLITZ COMMUNICATIONS GROUP LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | BLITZ COMMUNICATIONS GROUP LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04958145 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BLITZ COMMUNICATIONS GROUP LIMITED ?
Adresse du siège social | C/O Rsm Restructuring Advisory Llp Central Square 5th Floor 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BLITZ COMMUNICATIONS GROUP LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour BLITZ COMMUNICATIONS GROUP LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers | 14 pages | LIQ14 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Ges Silverstone Drive Gallagher Business Park Coventry CV6 6PA England à C/O Rsm Restructuring Advisory Llp Central Square 5th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL le 14 juin 2021 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration des affaires | 10 pages | LIQ02 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2019 au 30 déc. 2019 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 nov. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Ellen Marie Ingersoll le 20 févr. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 18 pages | AA | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Rsm Central Square 5th Floor, 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 nov. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jason Popp en tant que directeur le 20 sept. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Michael Stewart en tant que secrétaire le 09 janv. 2019 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Paul Mckenna Silverstone Drive Gallagher Business Park Coventry CV6 6PA à Ges Silverstone Drive Gallagher Business Park Coventry CV6 6PA le 09 janv. 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr Jason Popp en tant qu'administrateur le 09 janv. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nicholas John Marshall en tant que directeur le 09 janv. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Mckenna en tant que secrétaire le 09 janv. 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 nov. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 nov. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 nov. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 17 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de BLITZ COMMUNICATIONS GROUP LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEWART, Michael | Secrétaire | Central Square 5th Floor 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds C/O Rsm Restructuring Advisory Llp | 254108880001 | |||||||
INGERSOLL, Ellen Marie | Administrateur | Central Square 5th Floor 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds C/O Rsm Restructuring Advisory Llp | United States | American | Director | 90818150001 | ||||
MOSTER, Steven | Administrateur | Central Square 5th Floor 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds C/O Rsm Restructuring Advisory Llp | United States | American | Chairman, President And Ceo Of Viad Corp | 193607710001 | ||||
GORDON, Neil Arthur | Secrétaire | Stable Cottage, Burrows Lea Hook Lane, Shere GU5 9QQ Guildford Surrey | British | Company Director | 73989530001 | |||||
MAKANJI, Ashok | Secrétaire | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | 191996670001 | |||||||
MAKANJI, Ashok | Secrétaire | 100 Centennial Avenue Elstree WD6 3SA Hertfordshire | British | Director | 120367360001 | |||||
MCKENNA, Paul | Secrétaire | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | 193459040001 | |||||||
PATEL, Daxshaben | Secrétaire | 2 Millers Court Vicars Bridge Close HA0 1XG Alperton Middlesex | British | Company Director | 96045520001 | |||||
WATTS, Michael | Secrétaire | 100 Centennial Park Centennial Avenue, Elstree WD6 3SA Borehamwood Hertfordshire | British | Company Director | 116124970001 | |||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BEDDOW, Charles Edward Kenneth | Administrateur | Manor Road MK45 4NU Barton Le Clay 163 Bedfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 132281430001 | ||||
BREEN, Michael John | Administrateur | 47 Wieland Road HA6 3QX Northwood Middlesex | England | English | Company Director | 8442840002 | ||||
DYKSTRA, Paul Brian | Administrateur | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | Usa | American | Director | 118864330001 | ||||
GORDON, Neil Arthur | Administrateur | Stable Cottage, Burrows Lea Hook Lane, Shere GU5 9QQ Guildford Surrey | England | British | Company Director | 73989530001 | ||||
HUTTON, Paul William | Administrateur | 100 Centennial Avenue Elstree WD6 3SA Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 262424060001 | ||||
MAKANJI, Ashok | Administrateur | 100 Centennial Avenue Elstree WD6 3SA Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 120367360001 | ||||
MARSHALL, Nicholas John | Administrateur | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | England | British | Director | 20708530004 | ||||
POPP, Jason | Administrateur | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry Ges England | United States | American | Vice President | 254059920001 | ||||
SAMJI, Munir Akberali | Administrateur | 100 Centennial Avenue Elstree WD6 3SA Hertfordshire | United Kingdom | United Kingdom | Company Director | 119498620001 | ||||
WALSH, Jed | Administrateur | East 63rd Street New York 330 Apartment 4e 10065 United States | United States | United States | None | 148112610001 | ||||
WATTS, Michael | Administrateur | Bottle Lane SL6 3SB Littlewick Green Bay Tree Cottage Berks | British | Company Director | 133568510001 | |||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BLITZ COMMUNICATIONS GROUP LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viad Corp | 06 avr. 2016 | Suite 1900 Phoenix 1850 N Central Avenue Arizona 85004-4565 United States | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
BLITZ COMMUNICATIONS GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 05 févr. 2015 Livré le 16 févr. 2015 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 10 juil. 2009 Livré le 14 juil. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Stand-alone chattel mortgage | Créé le 27 juin 2007 Livré le 05 juil. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Equipment as per attached schedule of goods ref 128048/9. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A deed of assignment | Créé le 30 avr. 2004 Livré le 17 mai 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The company assigned with full title guarantee and agreed to assign absolutely its interest in and to the policies and the proceeds and the full benefit thereof;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 26 févr. 2004 Livré le 09 mars 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All f/h and l/h property, plant machinery vehicles computers and other equipment, stocks shares debentures bonds notes loan capital of any subsidiary any other body corporate and all rights, goodwill and uncalled capital, copyrights licences trademarks and patents, floating charge the undertaking and all property assets and rights present and future. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
BLITZ COMMUNICATIONS GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0