CS (GREENWICH) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCS (GREENWICH) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04958413
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CS (GREENWICH) LIMITED ?

    • Activités de projection de films cinématographiques (59140) / Information et communication

    Où se situe CS (GREENWICH) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8th Floor Vantage London
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    England
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CS (GREENWICH) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour CS (GREENWICH) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 14 juin 2017

    • Capital: GBP 0.01
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share prem a/c cancelled. Sum arising from reductions ne credited to a reserve 13/06/2017
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Modification des coordonnées du secrétaire Fiona Elizabeth Smith le 24 oct. 2016

    1 pagesCH03

    Déclaration de confirmation établie le 10 nov. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Retrait de la demande de radiation de la société

    1 pagesDS02

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Changement d'adresse du siège social de Power Road Studios 114 Power Road Chiswick London W4 5PY à 8th Floor Vantage London Great West Road Brentford England TW8 9AG le 25 oct. 2016

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    21 pagesAA

    Nomination de Matthew Neil Eyre en tant qu'administrateur le 08 août 2016

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Charlotte Abigail Brookmyre en tant que directeur le 08 août 2016

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 déc. 2015

    État du capital au 01 déc. 2015

    • Capital: GBP 16,500
    SH01

    Nomination de Keren Kedem en tant qu'administrateur le 01 juil. 2015

    3 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 01 janv. 2015

    17 pagesAA

    Cessation de la nomination de Philip Bowcock en tant que directeur le 09 juin 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 déc. 2014

    État du capital au 01 déc. 2014

    • Capital: GBP 16,500
    SH01

    Divers

    Section 519
    2 pagesMISC

    Divers

    Section 519 ca 2006
    3 pagesMISC

    Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Charlotte Abigail Buck le 27 août 2014

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 26 déc. 2013

    17 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CS (GREENWICH) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMITH, Fiona Elizabeth
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    Secrétaire
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    British182083490001
    EYRE, Matthew Neil
    c/o Cineworld Group Plc
    114 Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    England
    Administrateur
    c/o Cineworld Group Plc
    114 Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    England
    EnglandBritishNone213190620001
    KEREN, Merav
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    Administrateur
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    United KingdomIsraeliFinancial Director199412670001
    OATEY, Alastair Irven
    Lawrance Lea
    Harston
    CB22 7QR Cambridge
    3
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    Lawrance Lea
    Harston
    CB22 7QR Cambridge
    3
    Cambridgeshire
    British85567070003
    ENTERPRISE ADMINISTRATION LTD
    113-123 Upper Richmond Road
    SW15 2TL London
    Secrétaire
    113-123 Upper Richmond Road
    SW15 2TL London
    59811950001
    OLSWANG COSEC LIMITED
    High Holborn
    WC1V 6XX London
    90
    United Kingdom
    Secrétaire
    High Holborn
    WC1V 6XX London
    90
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement04051235
    83864780002
    BOWCOCK, Philip
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United Kingdom
    Administrateur
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector166007090001
    BROOKMYRE, Charlotte Abigail
    114 Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    Administrateur
    114 Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    EnglandBritishChartered Accountant160575040004
    BURGESS, Richard John
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    Administrateur
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)BritishAccountant35427700001
    GOLEBY, Lyn Mary
    Witnesham Hall Church Lane
    Witnesham
    IP6 9JD Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    Witnesham Hall Church Lane
    Witnesham
    IP6 9JD Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritishCinema Proprietor7611970003
    JERVIS, Vincent Gregory
    15 Durham Way
    SS6 9RY Rayleigh
    Essex
    Administrateur
    15 Durham Way
    SS6 9RY Rayleigh
    Essex
    United KingdomBritishFinancial Controller83038090001
    PHILLIPS, Susan Carole
    Coombe House Lodge
    124 Coombe Lane West
    KT2 7DD Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    Coombe House Lodge
    124 Coombe Lane West
    KT2 7DD Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritishSales Management24852020004
    SCOTT, Robert David Hillyer, Sir
    62 Crooms Hill
    Greenwich
    SE10 8HG London
    Administrateur
    62 Crooms Hill
    Greenwich
    SE10 8HG London
    EnglandBritishCompany Director59114680001
    STANFORD, Henry Julian Aglionby
    Chapel Farm, Fen Lane
    Forward Green
    IP14 5EF Stowmarket
    Suffolk
    Administrateur
    Chapel Farm, Fen Lane
    Forward Green
    IP14 5EF Stowmarket
    Suffolk
    EnglandBritishBanker62204660001
    WIENER, Stephen Mark
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United Kingdom
    Administrateur
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United Kingdom
    United KingdomUnited StatesDirector41603390004

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CS (GREENWICH) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    06 avr. 2016
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02310403
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    CS (GREENWICH) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Trust debenture
    Créé le 16 nov. 2009
    Livré le 24 nov. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Albion Protected Vct PLC
    Transactions
    • 24 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 avr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Trust debenture
    Créé le 22 déc. 2006
    Livré le 05 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Venture Capital Trust PLC
    Transactions
    • 05 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 sept. 2004
    Livré le 30 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the stockholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land having a frontage to greenwich high road at greenwich in the london borough of greenwich t/no SGL479719. All other f/h and l/h property, all plant machinery vehicles and other equipment, all investments, all negotiable instruments, all licences, the goodwill and uncalled capital and the undertaking and all other property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Healthcare and Leisure Property Fund PLC
    Transactions
    • 30 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 avr. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Trust debenture
    Créé le 24 sept. 2004
    Livré le 30 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the stockholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land having a frontage to greenwich high road at greenwich in the london borough of greenwich t/no SGL479719. All other f/h and l/h property, all plant machinery vehicles and other equipment, all investments, all negotiable instruments, all licences, the goodwill and uncalled capital and the undertaking and all other property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Venture Capital Trust PLC
    Transactions
    • 30 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0