KILMARTIN (SLOUGH) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKILMARTIN (SLOUGH) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04965656
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KILMARTIN (SLOUGH) LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe KILMARTIN (SLOUGH) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Updown Court
    Chertsey Road
    GU20 6HY Windlesham
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KILMARTIN (SLOUGH) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    COLMARTIN (SLOUGH) LIMITED17 nov. 200317 nov. 2003

    Quels sont les derniers comptes de KILMARTIN (SLOUGH) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour KILMARTIN (SLOUGH) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pages4.71

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 03 mars 2011

    LRESSP

    legacy

    4 pagesMG02

    Nomination de Mrs Susan Elizabeth Groat en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Susan Groat en tant que directeur

    2 pagesTM01

    legacy

    3 pagesMG02

    Période comptable précédente prolongée du 30 avr. 2010 au 31 oct. 2010

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 nov. 2010

    État du capital au 22 nov. 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Résolutions

    Resolutions
    29 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Gordon Bennet en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de The 6th Floor Coin House 2 Gees Court London W1U 1JA le 18 mars 2010

    2 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2009

    12 pagesAA

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Nomination de Gordon Iain Bennet en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Susan Elizabeth Groat en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robert Wotherspoon en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neil Mcguinness en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    29 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2008

    12 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de KILMARTIN (SLOUGH) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GROAT, Susan Elizabeth
    George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    93
    United Kingdom
    Administrateur
    George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    93
    United Kingdom
    ScotlandBritishProperty Developer88980540001
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    URQUHART, Roderick Macduff
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    Secrétaire
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    British562500001
    DWS SECRETARIES LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Secrétaire désigné
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900023840001
    TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Secrétaire
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    90707230001
    BENNET, Gordon Iain
    East Clyde Street
    G84 7AX Helensburgh
    152
    Dunbartonshire
    Administrateur
    East Clyde Street
    G84 7AX Helensburgh
    152
    Dunbartonshire
    United KingdomBritishChartered Accountant60009740002
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritishConsultant1267050001
    GROAT, Susan Elizabeth
    Castle Street
    EH2 5AH Edinburgh
    7
    Midlothian
    Administrateur
    Castle Street
    EH2 5AH Edinburgh
    7
    Midlothian
    ScotlandBritishProperty Developer88980540001
    MCGUINNESS, Neil Stephen
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    Administrateur
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    ScotlandBritishDirector83466350002
    MITCHELL, David Frank Robert
    8 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    Administrateur
    8 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    BritishDirector97869190001
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Administrateur
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritishChartered Surveyor69909950001
    WOTHERSPOON, Robert John
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    Administrateur
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    ScotlandBritishChartered Surveyor161858620001
    DWS DIRECTORS LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Administrateur désigné
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900023830001

    KILMARTIN (SLOUGH) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 28 nov. 2003
    Livré le 16 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a kingfisher court, farnham road, slough t/no BK261976 and BK263582. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 nov. 2003
    Livré le 29 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    KILMARTIN (SLOUGH) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 mars 2011Commencement of winding up
    25 févr. 2012Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Timothy Gerard Walsh
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    practitioner
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Laura May Waters
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0