ACORN (NO.18) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéACORN (NO.18) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04965664
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ACORN (NO.18) LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe ACORN (NO.18) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5 Prince's Gate
    London
    SW7 1QJ
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ACORN (NO.18) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KILMARTIN (NO.18) LIMITED13 janv. 200513 janv. 2005
    COLMARTIN (NO.18) LIMITED17 nov. 200317 nov. 2003

    Quels sont les derniers comptes de ACORN (NO.18) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour ACORN (NO.18) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 mars 2011 au 29 sept. 2011

    3 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2010

    16 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 déc. 2010

    État du capital au 14 déc. 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2010

    3 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    1 pagesCONNOT

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2009

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Duncan Barclay Roe le 17 déc. 2009

    3 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2009

    16 pagesAR01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    11 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    12 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2006

    12 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'assistance financière pour l'acquisition d'actions

    RES07

    legacy

    18 pages155(6)a

    legacy

    7 pages395

    legacy

    1 pages225

    legacy

    2 pages363a

    Qui sont les dirigeants de ACORN (NO.18) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LUCIE-SMITH, Derek
    17 South Eaton Place
    SW1W 9ER London
    Secrétaire
    17 South Eaton Place
    SW1W 9ER London
    British60313780001
    LUCIE-SMITH, Derek
    17 South Eaton Place
    SW1W 9ER London
    Administrateur
    17 South Eaton Place
    SW1W 9ER London
    United KingdomBritish60313780001
    ROE, Duncan Barclay
    Bracken Gardens
    SW13 9HW London
    1
    Administrateur
    Bracken Gardens
    SW13 9HW London
    1
    United KingdomBritish90999310004
    SMALLWOOD, Peter Whitworth
    Flat 2
    32 Alderney Street
    SW1V 4EU London
    Administrateur
    Flat 2
    32 Alderney Street
    SW1V 4EU London
    United KingdomBritish4211080008
    WORBOYS, Jeffery Stephen
    Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    4
    Administrateur
    Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    4
    United KingdomBritish122419590001
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    URQUHART, Roderick Macduff
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    Secrétaire
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    British562500001
    DWS SECRETARIES LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Secrétaire désigné
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900023840001
    TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Secrétaire
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    90707230001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    MCGUINNESS, Neil Stephen
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    Administrateur
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    United KingdomBritish83466350002
    MITCHELL, David Frank Robert
    8 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    Administrateur
    8 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    British97869190001
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Administrateur
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritish69909950001
    WOTHERSPOON, Robert John
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    Administrateur
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    ScotlandBritish161858620001
    DWS DIRECTORS LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Administrateur désigné
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900023830001

    ACORN (NO.18) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 10 mars 2006
    Livré le 14 mars 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the lender on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 56-58 guildford street, chertsey t/no SY724550. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transactions
    • 14 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 01 juil. 2005
    Livré le 14 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H property k/a 56-58 guildford street, chertsey t/no SY724550, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 14 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 24 nov. 2003
    Livré le 29 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 nov. 2003
    Livré le 29 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property known as 56-58 guildford street, chertsey. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0