ALAN DICK EUROPE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALAN DICK EUROPE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04971036
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALAN DICK EUROPE LIMITED ?

    • Autres activités de télécommunications (61900) / Information et communication

    Où se situe ALAN DICK EUROPE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o GRANT THORNTON UK LLP
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALAN DICK EUROPE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALAN DICK & COMPANY EUROPE LIMITED26 mars 200426 mars 2004
    ACRAMAN (352) LIMITED20 nov. 200320 nov. 2003

    Quels sont les derniers comptes de ALAN DICK EUROPE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ALAN DICK EUROPE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ALAN DICK EUROPE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    15 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 avr. 2014

    16 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP United Kingdom le 08 mai 2013

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 nov. 2012

    État du capital au 20 nov. 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de The Barlands London Road Cheltenham Gloucestershire GL52 6UT le 23 juil. 2012

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    15 pagesAA

    Nomination de Dr Robert Fisher en tant qu'administrateur le 16 déc. 2011

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jason Pearce en tant que directeur le 16 déc. 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jason Pearce en tant que secrétaire le 16 déc. 2011

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    accounts-with-accounts-type-

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de John Helas en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jason Pearce le 25 mars 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Jason Pearce le 25 mars 2010

    1 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Helas le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Tlt Secretaries Limited le 01 oct. 2009

    2 pagesCH04

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    16 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ALAN DICK EUROPE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TLT SECRETARIES LIMITED
    Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    One
    United Kingdom
    Secrétaire
    Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    One
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement02754253
    77278550001
    FISHER, Robert, Dr
    London Road
    Charlton Kings
    GL52 6UT Cheltenham
    The Barlands
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    London Road
    Charlton Kings
    GL52 6UT Cheltenham
    The Barlands
    Gloucestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector165452340001
    MURPHY, Paul
    34 King Henry Close
    GL53 7EZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    34 King Henry Close
    GL53 7EZ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishAccountant87441240001
    PEARCE, Jason
    Cowley
    GL53 9NJ Cheltenham
    Pound Cottage
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Cowley
    GL53 9NJ Cheltenham
    Pound Cottage
    Gloucestershire
    BritishDirector129915780001
    TLT SECRETARIES LIMITED
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    Secrétaire
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    77278550001
    CARRUTHERS, William
    Lambourne House
    Cider Mill Orchard
    GL55 6QZ Weston-Sub-Edge
    Gloucestershire
    Administrateur
    Lambourne House
    Cider Mill Orchard
    GL55 6QZ Weston-Sub-Edge
    Gloucestershire
    United KingdomBritishOperations Director72325990001
    DICK, Callum Andrew John
    9 Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Administrateur
    9 Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    EnglandBritishCompany Director118924270001
    DOST, Parminder Pal Singh
    8 Halland Way
    HA6 2AG Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    8 Halland Way
    HA6 2AG Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishDirector87287360001
    FISHER, Robert, Dr
    White Cross House
    Winterbrook
    OX10 9ED Wallingford
    Oxfordshire
    Administrateur
    White Cross House
    Winterbrook
    OX10 9ED Wallingford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector116981620001
    HELAS, John Peter
    Reading Road
    RG8 0LL Goring On Thames
    Waterloo Cottage
    South Oxfordshire
    Administrateur
    Reading Road
    RG8 0LL Goring On Thames
    Waterloo Cottage
    South Oxfordshire
    EnglandBritishDirector217758150001
    MURPHY, Paul
    34 King Henry Close
    GL53 7EZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    34 King Henry Close
    GL53 7EZ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishAccountant87441240001
    PEARCE, Jason Stephen
    Cowley
    GL53 9NJ Cheltenham
    Pound Cottage
    Gloucestershire
    Administrateur
    Cowley
    GL53 9NJ Cheltenham
    Pound Cottage
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector129915780002
    TLT DIRECTORS LIMITED
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    Administrateur
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    77278540002

    ALAN DICK EUROPE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 24 août 2006
    Livré le 31 août 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transactions
    • 31 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of accession to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 17 juil. 2006
    Livré le 18 juil. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Credit balances. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 18 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 13 juin 2005
    Livré le 30 juin 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 30 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 13 juin 2005
    Livré le 24 juin 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and each of the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Agent and Security Trustee for Each of the Finance Parties) (Thesecurity Trustee)
    Transactions
    • 24 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)

    ALAN DICK EUROPE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 avr. 2013Commencement of winding up
    08 avr. 2015Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas Stewart Wood
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YC London
    practitioner
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YC London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0