CONTINENTAL SHELF 291 LIMITED

CONTINENTAL SHELF 291 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCONTINENTAL SHELF 291 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04978146
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CONTINENTAL SHELF 291 LIMITED ?

    • Activités des autres sociétés holding n.c.a. (64209) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe CONTINENTAL SHELF 291 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CONTINENTAL SHELF 291 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour CONTINENTAL SHELF 291 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    16 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 août 2018

    12 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 août 2017

    13 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 août 2016

    7 pages4.68

    Déclaration de solvabilité

    5 pages4.70

    Changement d'adresse du siège social de 18th Floor 33 Cavendish Square London W1G 0PW à 4 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells Kent TN1 1EE le 21 août 2015

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 07 août 2015

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Gary John Mccabe en tant que directeur le 21 avr. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2015

    4 pagesAA

    Deuxième dépôt de AR01 précédemment soumis à Companies House mis à jour jusqu'au 27 déc. 2014

    16 pagesRP04

    Cessation de la nomination de Malcolm Robin Turner en tant que directeur le 24 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 janv. 2015

    État du capital au 06 janv. 2015

    • Capital: GBP 20,250,000
    SH01
    capital06 janv. 2015

    État du capital au 26 janv. 2015

    • Capital: GBP 19,990,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Stephane Abraham Joseph Nahum en tant que directeur le 24 nov. 2014

    2 pagesTM01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 02 déc. 2014

    • Capital: GBP 19,990,000
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Nomination de Mr Christakis Christofi en tant qu'administrateur le 01 juin 2014

    3 pagesAP01

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014

    4 pagesAA

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 janv. 2014

    État du capital au 14 janv. 2014

    • Capital: GBP 20,250,000
    SH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2012

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CONTINENTAL SHELF 291 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHRISTOFI, Christakis, Mr.
    10 Litchfield Way
    NW11 6NJ London
    Secrétaire
    10 Litchfield Way
    NW11 6NJ London
    British67125820002
    CHRISTOFI, Christakis, Mr.
    Litchfield Way
    NW11 6NJ London
    10
    England
    Administrateur
    Litchfield Way
    NW11 6NJ London
    10
    England
    EnglandBritish67125820002
    SCOTT, Keith
    Clarendon Road
    HP16 0PL Prestwood
    Michaelmas Farm
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Clarendon Road
    HP16 0PL Prestwood
    Michaelmas Farm
    Buckinghamshire
    British141163370001
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Secrétaire désigné
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001
    ANDERSON, Bruce Smith
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    Administrateur
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    ScotlandBritish73849040001
    HEWITT, Alistair James Neil
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandBritish113081830001
    KASCH, Peter Carwile
    Filston Oast
    Filston Lane
    TN14 5JU Shoreham
    Kent
    Administrateur
    Filston Oast
    Filston Lane
    TN14 5JU Shoreham
    Kent
    United KingdomBritish61386600003
    MACKINTOSH, Iain Stewart
    9 Greenbank Terrace
    EH10 6ER Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    9 Greenbank Terrace
    EH10 6ER Edinburgh
    Midlothian
    British94163020001
    MCCABE, Gary John
    Cleuch Avenue
    North Middleton
    EH23 4RP Gorebridge
    6
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    Cleuch Avenue
    North Middleton
    EH23 4RP Gorebridge
    6
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritish139525550001
    MCCABE, Gary John
    Cleuch Avenue
    North Middleton
    EH23 4RP Gorebridge
    6
    Midlothian
    Administrateur
    Cleuch Avenue
    North Middleton
    EH23 4RP Gorebridge
    6
    Midlothian
    ScotlandBritish139525550001
    MCMAHON, James Cairns
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    Administrateur
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    ScotlandBritish159708270001
    NAHUM, Stephane Abraham Joseph
    21a Kensington High Street
    W8 5NP London
    Administrateur
    21a Kensington High Street
    W8 5NP London
    EnglandFrench99292580003
    SELLAR, Gillian Christine
    112 Seaview Terrace
    EH15 2HQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    112 Seaview Terrace
    EH15 2HQ Edinburgh
    Midlothian
    British107180940001
    TRIBE, Nicholas John Grove
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    Administrateur
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritish141163390001
    TURNER, Malcolm Robin
    18 Jay Mews
    SW7 2EP London
    Administrateur
    18 Jay Mews
    SW7 2EP London
    United KingdomBritish60293070001
    MD DIRECTORS LIMITED
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    Administrateur désigné
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    900005100001

    CONTINENTAL SHELF 291 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 04 mars 2004
    Livré le 19 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of a first floating charge the whole property (including uncalled capital) which is or may be from time to time comprised in the property and undertaking of the charge.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee and Agent for the Financeparties
    Transactions
    • 19 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 déc. 2003
    Livré le 31 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the security trustee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 31 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CONTINENTAL SHELF 291 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 août 2015Commencement of winding up
    15 févr. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Newman
    Crowe U.K. Llp 4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    practitioner
    Crowe U.K. Llp 4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Vincent John Green
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    practitioner
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0