AXIS INTERMODAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAXIS INTERMODAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04980247
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AXIS INTERMODAL LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe AXIS INTERMODAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Frp Advisory Llp 2nd Floor
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AXIS INTERMODAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AXIS INTERMODAL PLC04 janv. 200704 janv. 2007
    INTERMODAL RESOURCE PLC01 déc. 200301 déc. 2003

    Quels sont les derniers comptes de AXIS INTERMODAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour AXIS INTERMODAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    18 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 août 2021

    17 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 août 2020

    17 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de 8th Floor Reading Bridge House George Street Reading RG1 8LS England à Frp Advisory Llp 2nd Floor 170 Edmund Street Birmingham B3 2HB le 11 sept. 2019

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires

    15 pagesLIQ02

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 27 août 2019

    LRESEX

    Changement d'adresse du siège social de 14 Fenlock Court Lower Road Long Hanborough Oxfordshire OX29 8LN England à 8th Floor Reading Bridge House George Street Reading RG1 8LS le 24 juin 2019

    1 pagesAD01

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2018

    39 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Juliet Lisa Mash en tant que secrétaire le 06 nov. 2018

    1 pagesTM02

    Cessation de Silke Montague en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    1 pagesPSC07

    Nomination de Ms Juliet Lisa Mash en tant que secrétaire le 23 avr. 2018

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Claire-Louise Maria Cook en tant que secrétaire le 23 avr. 2018

    1 pagesTM02

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2017

    42 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mrs Claire-Louise Maria Cook en tant que secrétaire le 24 oct. 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Nicolas Handran Smith en tant que secrétaire le 24 oct. 2017

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de 15 Fenlock Court Lower Road Long Hanborough Oxfordshire OX29 8LN à 14 Fenlock Court Lower Road Long Hanborough Oxfordshire OX29 8LN le 21 avr. 2017

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Nicolas Handran Smith en tant que secrétaire le 31 janv. 2017

    2 pagesAP03

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2016 avec mises à jour

    12 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2016

    41 pagesAA

    État du capital après une attribution d'actions au 15 avr. 2016

    • Capital: GBP 3,379,044
    3 pagesSH01

    État du capital après une attribution d'actions au 16 févr. 2016

    • Capital: GBP 3,302,544
    4 pagesSH01

    Qui sont les dirigeants de AXIS INTERMODAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BALL, Stephen James
    2nd Floor
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Frp Advisory Llp
    Administrateur
    2nd Floor
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Frp Advisory Llp
    GuernseyBritishDirector64791080003
    MONTAGUE, Robert Joel
    2nd Floor
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Frp Advisory Llp
    Administrateur
    2nd Floor
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Frp Advisory Llp
    United KingdomBritishDirector153022690002
    BALL, Stephen James
    La Cloture
    Rocque Balan Lane, Vale
    GY3 5AL Guernsey
    Channel Islands
    Secrétaire
    La Cloture
    Rocque Balan Lane, Vale
    GY3 5AL Guernsey
    Channel Islands
    BritishManaging Director64791080003
    COOK, Claire-Louise Maria
    Fenlock Court
    Lower Road
    OX29 8LN Long Hanborough
    14
    Oxfordshire
    England
    Secrétaire
    Fenlock Court
    Lower Road
    OX29 8LN Long Hanborough
    14
    Oxfordshire
    England
    239367680001
    CORMACK, Derek George
    Pillars
    Grantley Avenue, Wonersh
    GU5 0QN Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    Pillars
    Grantley Avenue, Wonersh
    GU5 0QN Guildford
    Surrey
    IrishChartered Accountant67400530015
    MASH, Juliet Lisa
    Fenlock Court
    Lower Road
    OX29 8LN Long Hanborough
    14
    Oxfordshire
    England
    Secrétaire
    Fenlock Court
    Lower Road
    OX29 8LN Long Hanborough
    14
    Oxfordshire
    England
    245622570001
    SMITH, Nicholas Handran
    15 Fenlock Court
    Lower Road
    OX29 8LN Long Hanborough
    Oxfordshire
    Secrétaire
    15 Fenlock Court
    Lower Road
    OX29 8LN Long Hanborough
    Oxfordshire
    AustralianSolicitor88031090001
    SMITH, Nicolas Handran
    Fenlock Court
    Lower Road
    OX29 8LN Long Hanborough
    14
    Oxfordshire
    England
    Secrétaire
    Fenlock Court
    Lower Road
    OX29 8LN Long Hanborough
    14
    Oxfordshire
    England
    223888500001
    ACI SECRETARIES LIMITED
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Secrétaire désigné
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900027740001
    CANVIN, George
    Ruffle House
    Ruffles Yard Castle Hedingham
    CO9 3ED Halstead
    Essex
    Administrateur
    Ruffle House
    Ruffles Yard Castle Hedingham
    CO9 3ED Halstead
    Essex
    United KingdomBritishDirector97558700001
    CLEMSON, Ernest Arthur
    7 Southview
    135 Hornsey Lane Highgate
    N6 5NR London
    Administrateur
    7 Southview
    135 Hornsey Lane Highgate
    N6 5NR London
    United KingdomBritishDirector62891600003
    CORMACK, Derek George
    Pillars
    Grantley Avenue, Wonersh
    GU5 0QN Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Pillars
    Grantley Avenue, Wonersh
    GU5 0QN Guildford
    Surrey
    EnglandIrishChartered Accountant67400530015
    DEXTER, Stephen Kenneth
    15 Fenlock Court
    Lower Road
    OX29 8LN Long Hanborough
    Oxfordshire
    Administrateur
    15 Fenlock Court
    Lower Road
    OX29 8LN Long Hanborough
    Oxfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant12068330001
    FRANCIS, Clive Edmund
    Rudgwick
    96a Chipstead Lane
    TN13 2AQ Riverhead
    Kent
    Administrateur
    Rudgwick
    96a Chipstead Lane
    TN13 2AQ Riverhead
    Kent
    United KingdomBritishDirector155819860001
    FROME, Andrew
    The Island Mill
    Union Lane
    RG20 4SS Kingsclere
    Berkshire
    Administrateur
    The Island Mill
    Union Lane
    RG20 4SS Kingsclere
    Berkshire
    BritishAccountant121407350001
    MANGELS, Heiner
    15 Fenlock Court
    Lower Road
    OX29 8LN Long Hanborough
    Oxfordshire
    Administrateur
    15 Fenlock Court
    Lower Road
    OX29 8LN Long Hanborough
    Oxfordshire
    GermanyGermanDirector118972090002
    POTTER, David Michael
    15 Fenlock Court
    Lower Road
    OX29 8LN Long Hanborough
    Oxfordshire
    Administrateur
    15 Fenlock Court
    Lower Road
    OX29 8LN Long Hanborough
    Oxfordshire
    EnglandBritishManaging Director150724620001
    ROGERS, Christopher Robin
    Shillington Manor Apsley End Road
    Shillington
    SG5 3LD Hitchin
    Hertfordshire
    Administrateur
    Shillington Manor Apsley End Road
    Shillington
    SG5 3LD Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector12674160002
    SMITH, Nicholas Handran
    15 Fenlock Court
    Lower Road
    OX29 8LN Long Hanborough
    Oxfordshire
    Administrateur
    15 Fenlock Court
    Lower Road
    OX29 8LN Long Hanborough
    Oxfordshire
    EnglandAustralianSolicitor88031090001
    ACI DIRECTORS LIMITED
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Administrateur désigné
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900027730001
    ACI SECRETARIES LIMITED
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Administrateur désigné
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900027740001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AXIS INTERMODAL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mrs Silke Montague
    Fenlock Court
    Lower Road
    OX29 8LN Long Hanborough
    14
    Oxfordshire
    England
    06 avr. 2016
    Fenlock Court
    Lower Road
    OX29 8LN Long Hanborough
    14
    Oxfordshire
    England
    Oui
    Nationalité: German
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mr Robert Joel Montague
    2nd Floor
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Frp Advisory Llp
    06 avr. 2016
    2nd Floor
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Frp Advisory Llp
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    AXIS INTERMODAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 12 mai 2009
    Livré le 27 mai 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Co
    Transactions
    • 27 mai 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 10 mai 2007
    Livré le 12 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 20 april 2005 and
    Créé le 31 oct. 2006
    Livré le 08 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies due or to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefits of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assignment agreements.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 08 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 20TH april 2005 and
    Créé le 16 janv. 2006
    Livré le 24 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies due or to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule. The benefits of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assignment agreements.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 24 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 20TH april 2005
    Créé le 12 oct. 2005
    Livré le 27 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies due or to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefits of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assignment agreements.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 27 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 20 april 2005
    Créé le 05 oct. 2005
    Livré le 20 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies due under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment (the assigned agreements) the benefit of all guarantees, indemnities, negotiable instruments and securities in connection to the assigned agreements.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 20TH april 2005 and
    Créé le 04 oct. 2005
    Livré le 06 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies due or to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefits of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assignment agreements.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 20TH april 2005 and
    Créé le 04 oct. 2005
    Livré le 06 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies due or to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefits of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assignment agreements.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 20TH april 2005
    Créé le 17 août 2005
    Livré le 25 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies due or to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefits of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assignment agreements.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 25 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Certificate of assignment pursuant to a master agreement dated 20TH april 2005 and
    Créé le 20 juil. 2005
    Livré le 22 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies due or to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefits of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assignment agreements.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 22 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 20 april 2005
    Créé le 06 juil. 2005
    Livré le 14 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies due under the sub-hire agreements specified in the schedule (the assigned agreements) and the benefit of all guarantees, indemnities, negotiable instruments and securities in connection to the assigned agreements.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Certificate assignment pursuant to a master assignment dated 20/04/05
    Créé le 26 mai 2005
    Livré le 08 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies due or to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefits of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assignment agreements.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 08 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 20/04/05
    Créé le 23 mai 2005
    Livré le 08 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies due or to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefits of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assignment agreements.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 08 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Certificate of assignment
    Créé le 06 mai 2005
    Livré le 17 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Sub-hire agreement no. Ltra-TR4 description of vehicle 3X dennison tri-axle air suspension sliding bogie skeletal trailers. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 17 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Certificate of assignment
    Créé le 06 mai 2005
    Livré le 17 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Sub-hire agreement no.ltra-TR7 description of vehicles dennison TR1 axle 14 lock sliding skeletal trailer X3 chassis nos 16292, 16357, 16359. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 17 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    AXIS INTERMODAL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 août 2019Commencement of winding up
    15 mars 2022Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Miles Needham
    4 Beaconsfield Road
    AL1 3RD St Albans
    Hertfordshire
    practitioner
    4 Beaconsfield Road
    AL1 3RD St Albans
    Hertfordshire
    Raj Mittal
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    practitioner
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0