MENDIP LAND LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MENDIP LAND LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04980972 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MENDIP LAND LIMITED ?
| Adresse du siège social | 7a Howick Place SW1P 1DZ London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MENDIP LAND LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 29 févr. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour MENDIP LAND LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Matthew Richard Potter en tant qu'administrateur le 25 sept. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Bradley David Cassels en tant que directeur le 29 sept. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 déc. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 29 févr. 2016 | 21 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Henry Marx en tant que directeur le 29 févr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Richard Upton en tant qu'administrateur le 08 févr. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Bradley David Cassels en tant qu'administrateur le 08 févr. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 049809720008 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 049809720007 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Henry Marx le 09 nov. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Matthew Simon Weiner le 09 nov. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Chris Barton le 09 nov. 2015 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 28 févr. 2015 | 20 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Portland House Bressenden Place London SW1E 5DS à 7a Howick Place London SW1P 1DZ le 11 nov. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr Chris Barton en tant que secrétaire le 05 janv. 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Marcus Owen Shepherd en tant que secrétaire le 05 janv. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 28 févr. 2014 | 16 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Marcus Owen Shepherd en tant que secrétaire le 01 sept. 2014 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Helen Maria Ratsey en tant que secrétaire le 01 sept. 2014 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MENDIP LAND LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTON, Chris | Secrétaire | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | 194344050001 | |||||||
| POTTER, Matthew Richard | Administrateur | Howick Place SW1P 1DZ London 7a | England | British | 207231520001 | |||||
| UPTON, Richard | Administrateur | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | England | British | 204950320001 | |||||
| WEINER, Matthew Simon | Administrateur | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | United Kingdom | British | 72888710002 | |||||
| LANES, Stephen Alec | Secrétaire | Thorpe House 105 Mycenae Road Blackheath SE3 7RX London | British | 1266100003 | ||||||
| LANGRIDGE, Megan Joy | Secrétaire | 42 Everest Drive Hoo St Werburgh ME3 9AW Rochester Kent | British | 86459820005 | ||||||
| O REILLY NEENAN, Marie | Secrétaire | Pump House Kilmurry Sixmilebridge IRISH Ennis County Clare Ireland | Irish | 112443260001 | ||||||
| RATSEY, Helen Maria | Secrétaire | Bressenden Place SW1E 5DS London Portland House England | British | 158444560001 | ||||||
| SHEPHERD, Marcus Owen | Secrétaire | Bressenden Place SW1E 5DS London Portland House England England | 190695330001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| CASSELS, Bradley David | Administrateur | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | United Kingdom | British | 130724370005 | |||||
| HAMMOND, Arnold David | Administrateur | PO BOX 4532 8 Mandarina St Casearea 38900 Israel | British | 96187460001 | ||||||
| HAMMOND, Oliver James | Administrateur | 26 Lewes Way Croxley Green WD3 3SN Rickmansworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 54758590002 | |||||
| KLIMT, Peter Richard | Administrateur | Redington Road NW3 7RS London 54 | United Kingdom | British | 23621230001 | |||||
| LAKER, John Frederick | Administrateur | 57 Greenways KT10 0QH Hinchley Woods Surrey | United Kingdom | British | 54651510001 | |||||
| MARSH, John Charles | Administrateur | 115 Upper Grosvenor Road TN1 2EA Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 85346010001 | |||||
| MARX, Michael Henry | Administrateur | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | United Kingdom | British | 35019090001 | |||||
| NAGGAR, Guy Anthony | Administrateur | Avenue Road NW8 6HR London 61 | United Kingdom | Italian | 1496660001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MENDIP LAND LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Development Securities (Wells) Limited | 06 avr. 2016 | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
MENDIP LAND LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 15 mai 2014 Livré le 23 mai 2014 | Totalement satisfaite | ||
Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 25 oct. 2013 Livré le 01 nov. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A tenth supplemental trust deed | Créé le 03 févr. 2009 Livré le 05 févr. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti £20,000,000 and all other monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery. F/h 18 priory road wells somerset t/no ST99267. F/h kwik-fit depot wells somerset t/no ST105789. F/h 38 market street wells somerset t/no ST68067 and WS30048 see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of assignment | Créé le 26 nov. 2004 Livré le 10 déc. 2004 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from starlight investments limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The F.h land known as 18 priory road wells ST99267 f/h land known as land on the south side of market street wells t/n ST68067 f/h land known as kwik fit depot princes road wells t/n ST105789,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Supplemental deed supplemental to a deed of legal charge dated 30 august 2002 | Créé le 26 nov. 2004 Livré le 10 déc. 2004 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from starlight investments limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The f/h land known as 18 priory road wells t/n ST99267 f/h land known as land on the south side of market street wells part st 68067, f/h land known as kwik fit depot princes road wells t/n st 105789, together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fittings thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any),. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 12 mai 2004 Livré le 15 mai 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of legal mortgage f/h property k/a autospeed tyre & exhaust depot, princes road, wells, mendip, somerset (more recently k/a the kwik fit depot, princes road, wells) t/n ST105789. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 12 févr. 2004 Livré le 17 févr. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 12 févr. 2004 Livré le 17 févr. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All that f/h property known as 18 priory road, wells, mendip, somerset BA5 1SY t/n ST99267. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0