MENDIP LAND LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMENDIP LAND LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04980972
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MENDIP LAND LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe MENDIP LAND LIMITED ?

    Adresse du siège social
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MENDIP LAND LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    STAMPVOCAL LIMITED01 déc. 200301 déc. 2003

    Quels sont les derniers comptes de MENDIP LAND LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 févr. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour MENDIP LAND LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Mr Matthew Richard Potter en tant qu'administrateur le 25 sept. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Bradley David Cassels en tant que directeur le 29 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 23 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 29 févr. 2016

    21 pagesAA

    Cessation de la nomination de Michael Henry Marx en tant que directeur le 29 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Richard Upton en tant qu'administrateur le 08 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Bradley David Cassels en tant qu'administrateur le 08 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Satisfaction de la charge 049809720008 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 049809720007 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 déc. 2015

    État du capital au 23 déc. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Henry Marx le 09 nov. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Matthew Simon Weiner le 09 nov. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Chris Barton le 09 nov. 2015

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 28 févr. 2015

    20 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Portland House Bressenden Place London SW1E 5DS à 7a Howick Place London SW1P 1DZ le 11 nov. 2015

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Chris Barton en tant que secrétaire le 05 janv. 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Marcus Owen Shepherd en tant que secrétaire le 05 janv. 2015

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 déc. 2014

    État du capital au 24 déc. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 28 févr. 2014

    16 pagesAA

    Nomination de Mr Marcus Owen Shepherd en tant que secrétaire le 01 sept. 2014

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Helen Maria Ratsey en tant que secrétaire le 01 sept. 2014

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de MENDIP LAND LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARTON, Chris
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Secrétaire
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    194344050001
    POTTER, Matthew Richard
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    Administrateur
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    EnglandBritish207231520001
    UPTON, Richard
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Administrateur
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    EnglandBritish204950320001
    WEINER, Matthew Simon
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Administrateur
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish72888710002
    LANES, Stephen Alec
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    Secrétaire
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    British1266100003
    LANGRIDGE, Megan Joy
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    Secrétaire
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    British86459820005
    O REILLY NEENAN, Marie
    Pump House
    Kilmurry Sixmilebridge
    IRISH Ennis
    County Clare
    Ireland
    Secrétaire
    Pump House
    Kilmurry Sixmilebridge
    IRISH Ennis
    County Clare
    Ireland
    Irish112443260001
    RATSEY, Helen Maria
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    Secrétaire
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    British158444560001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    Secrétaire
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    190695330001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CASSELS, Bradley David
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Administrateur
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish130724370005
    HAMMOND, Arnold David
    PO BOX 4532
    8 Mandarina St
    Casearea
    38900
    Israel
    Administrateur
    PO BOX 4532
    8 Mandarina St
    Casearea
    38900
    Israel
    British96187460001
    HAMMOND, Oliver James
    26 Lewes Way
    Croxley Green
    WD3 3SN Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    26 Lewes Way
    Croxley Green
    WD3 3SN Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish54758590002
    KLIMT, Peter Richard
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    Administrateur
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    United KingdomBritish23621230001
    LAKER, John Frederick
    57 Greenways
    KT10 0QH Hinchley Woods
    Surrey
    Administrateur
    57 Greenways
    KT10 0QH Hinchley Woods
    Surrey
    United KingdomBritish54651510001
    MARSH, John Charles
    115 Upper Grosvenor Road
    TN1 2EA Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    115 Upper Grosvenor Road
    TN1 2EA Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish85346010001
    MARX, Michael Henry
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Administrateur
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish35019090001
    NAGGAR, Guy Anthony
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    Administrateur
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    United KingdomItalian1496660001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MENDIP LAND LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05755148
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    MENDIP LAND LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 15 mai 2014
    Livré le 23 mai 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transactions
    • 23 mai 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 25 oct. 2013
    Livré le 01 nov. 2013
    Totalement satisfaite
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transactions
    • 01 nov. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A tenth supplemental trust deed
    Créé le 03 févr. 2009
    Livré le 05 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £20,000,000 and all other monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery. F/h 18 priory road wells somerset t/no ST99267. F/h kwik-fit depot wells somerset t/no ST105789. F/h 38 market street wells somerset t/no ST68067 and WS30048 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transactions
    • 05 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment
    Créé le 26 nov. 2004
    Livré le 10 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from starlight investments limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The F.h land known as 18 priory road wells ST99267 f/h land known as land on the south side of market street wells t/n ST68067 f/h land known as kwik fit depot princes road wells t/n ST105789,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 10 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental deed supplemental to a deed of legal charge dated 30 august 2002
    Créé le 26 nov. 2004
    Livré le 10 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from starlight investments limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h land known as 18 priory road wells t/n ST99267 f/h land known as land on the south side of market street wells part st 68067, f/h land known as kwik fit depot princes road wells t/n st 105789, together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fittings thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any),. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 10 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 12 mai 2004
    Livré le 15 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage f/h property k/a autospeed tyre & exhaust depot, princes road, wells, mendip, somerset (more recently k/a the kwik fit depot, princes road, wells) t/n ST105789. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 févr. 2004
    Livré le 17 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 févr. 2004
    Livré le 17 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h property known as 18 priory road, wells, mendip, somerset BA5 1SY t/n ST99267. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0