AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
| Numéro de société | 04985335 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED ?
| Adresse du siège social | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Phillimore Clifford en tant que directeur le 28 mars 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2018 | 18 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 déc. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2017 | 16 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Sui Sang Leung en tant que directeur le 22 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Henry Maxwell Oliver en tant que directeur le 22 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Stuart Wilcox en tant que directeur le 22 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Dominic Gibb en tant que directeur le 22 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Hilke Farina en tant que directeur le 22 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Chris Blease en tant que directeur le 22 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Amicushorizon Limited le 22 mai 2017 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Statuts | 15 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 déc. 2016 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2016 | 16 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 déc. 2015 sans liste des membres | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2015 | 14 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mrs Hilke Farina en tant qu'administrateur le 21 mai 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Stuart Wilcox en tant qu'administrateur le 01 mai 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIVO | Secrétaire | 125 High Street CR0 9XP Croydon Grosvenor House Surrey United Kingdom |
| 81186300007 | ||||||||||||||
| EVANS, Daniel | Secrétaire | Trowers & Hamlins Sceptre Court 40 Tower Hill EC3N 4DX London | British | 94303280001 | ||||||||||||||
| AARONS, Leslie Ian | Administrateur | Briarwood House 11 Briarwood Hill CR8 3LF Purley Surrey | British | 103151160001 | ||||||||||||||
| BAKER, Trevor Charles | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 26767780006 | ||||||||||||||
| BLEASE, Chris | Administrateur | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | England | British | 174349810001 | |||||||||||||
| BURKE, Martin Joseph | Administrateur | 31 Garrard Road SM7 2ER Banstead Surrey | England | British | 80091720001 | |||||||||||||
| CAMPBELL, Rory Gerald Peter | Administrateur | Trowers & Hamlins Sceptre Court 40 Tower Hill EC3N 4DX London | British | 94303270001 | ||||||||||||||
| CHILEMBA, Harneck | Administrateur | 112b Erlanger Road Telegraph Hill Park SE14 5TJ London | Malawian | 96356850001 | ||||||||||||||
| CLIFFORD, David Phillimore | Administrateur | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | United Kingdom | British | 197049630001 | |||||||||||||
| COOPER, Peter Harry | Administrateur | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | England | British | 100351860001 | |||||||||||||
| CRUTTENDEN, Peter | Administrateur | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | England | British | 79421300001 | |||||||||||||
| CUDD, John Charles | Administrateur | 4 Walnut Tree Walk BN20 9BP Eastbourne East Sussex | England | British | 113934990001 | |||||||||||||
| DICKINSON MA, David John | Administrateur | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | United Kingdom | British | 139132630001 | |||||||||||||
| EVANS, Daniel | Administrateur | Trowers & Hamlins Sceptre Court 40 Tower Hill EC3N 4DX London | British | 94303280001 | ||||||||||||||
| FALCONER, Charles Leslie, Lord | Administrateur | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | United Kingdom | British | 36324370001 | |||||||||||||
| FARINA, Hilke | Administrateur | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | England | Irish | 200319020001 | |||||||||||||
| GIBB, Dominic | Administrateur | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | United Kingdom | British | 187068870001 | |||||||||||||
| HARLAND, Stuart | Administrateur | Knellstone House Udimore TN31 6AR Rye East Sussex | British | 114759590001 | ||||||||||||||
| HARRIOTT, Stephen | Administrateur | 6 Quay Court Westmeads Road CT5 1QZ Whitstable Kent | British | 113561590001 | ||||||||||||||
| HOLES, Eric | Administrateur | 2 Stable Courtyard Chelwood Vachery TN22 3HR Nutley East Sussex | England | British | 90452390001 | |||||||||||||
| INGRAM, Owen | Administrateur | 6 Arbor Close BR3 6TW Beckenham Kent | United Kingdom | British | 103630530001 | |||||||||||||
| KOTTEGODA, Siraj, Mr. | Administrateur | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | England | British | 99206180001 | |||||||||||||
| LEUNG, Stephen Sui Sang | Administrateur | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | United Kingdom | British | 196161690001 | |||||||||||||
| NEWSAM, Denise Feshina Philippa | Administrateur | 32 Garlies Road Forest Hill SE23 2RT London | United Kingdom | British | 96357030001 | |||||||||||||
| OLASODE, Olusegun Ayodeji, Dr | Administrateur | New Orchard House 2a Monks Orchard Road, West Wickham BR3 3BW Beckenham Kent | United Kingdom | British | 52287010003 | |||||||||||||
| OLIVER, David Henry Maxwell | Administrateur | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | United Kingdom | British | 67052550001 | |||||||||||||
| PANTER, Andrew | Administrateur | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | England | British | 52734470001 | |||||||||||||
| SMITH, Dennis Michael | Administrateur | Treetops 57 Battery Hill Fairlight TN35 4AP Hastings East Sussex | United Kingdom | British | 69832870003 | |||||||||||||
| SMITH, Sarah Anne | Administrateur | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | United Kingdom | British | 127972360001 | |||||||||||||
| STARKE, Christopher Charles | Administrateur | 35 Byng Road TN4 8EG Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 62786710003 | |||||||||||||
| WALKER, Stephen | Administrateur | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | Uk | British | 113110240002 | |||||||||||||
| WILCOX, Simon Stuart | Administrateur | Grosvenor House 125 High Street CR0 9XP Croydon Surrey | England | British | 198724310001 | |||||||||||||
| WILSON, Ben | Administrateur | Apartment 17 Tower 1 416 Manchester Road E14 3RD London | England | British | 90171030001 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 04 déc. 2016 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed charge | Créé le 06 janv. 2011 Livré le 13 janv. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions First fixed charge all the chargor's rights title and interest from time to time in and to each of the following assets the facilities account and all moneys now or at any time in future standing to the credit of the facilities account see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 17 déc. 2010 Livré le 22 déc. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first floating charge the whole of the chargor's undertaking and assets present and future all rights and claims to which the chargor is now or may hereafter become entitled in relation to all moneys now or at any time hereafter standing to the credit of the agf sinking fund together with all the rights relating of attaching hereto see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed charge | Créé le 14 févr. 2007 Livré le 02 mars 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All the right title and interest from time to time in and to each of the following assets, the facilities account and all rights and claims in relation to all moneys. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 26 mars 2004 Livré le 15 avr. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All rights and claims in relation to all moneys standing to the credit of the hgf sinking fund together with all rights relating or attaching thereto, all rights of the chargor under or in respect of the documents,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0