AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED

AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société 04985335
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HORIZON GROUP FINANCING LIMITED 04 déc. 200304 déc. 2003

    Quels sont les derniers comptes de AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de David Phillimore Clifford en tant que directeur le 28 mars 2018

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 mars 2018

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2017

    16 pagesAA

    Cessation de la nomination de Stephen Sui Sang Leung en tant que directeur le 22 mai 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Henry Maxwell Oliver en tant que directeur le 22 mai 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Simon Stuart Wilcox en tant que directeur le 22 mai 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Dominic Gibb en tant que directeur le 22 mai 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Hilke Farina en tant que directeur le 22 mai 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Chris Blease en tant que directeur le 22 mai 2017

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées du secrétaire Amicushorizon Limited le 22 mai 2017

    1 pagesCH04

    Statuts

    15 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Déclaration de confirmation établie le 04 déc. 2016 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 déc. 2015 sans liste des membres

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    14 pagesAA

    Nomination de Mrs Hilke Farina en tant qu'administrateur le 21 mai 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Simon Stuart Wilcox en tant qu'administrateur le 01 mai 2015

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OPTIVO
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Grosvenor House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Grosvenor House
    Surrey
    United Kingdom
    Forme juridiqueCOMMUNITY BENEFIT SOCIETY
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleCO-OPERATIVE & COMMUNITY BENEFIT ACT 2011
    Numéro d'enregistrement7561
    81186300007
    EVANS, Daniel
    Trowers & Hamlins
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    Secrétaire
    Trowers & Hamlins
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    British94303280001
    AARONS, Leslie Ian
    Briarwood House
    11 Briarwood Hill
    CR8 3LF Purley
    Surrey
    Administrateur
    Briarwood House
    11 Briarwood Hill
    CR8 3LF Purley
    Surrey
    British103151160001
    BAKER, Trevor Charles
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Administrateur
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British26767780006
    BLEASE, Chris
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Administrateur
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandBritish174349810001
    BURKE, Martin Joseph
    31 Garrard Road
    SM7 2ER Banstead
    Surrey
    Administrateur
    31 Garrard Road
    SM7 2ER Banstead
    Surrey
    EnglandBritish80091720001
    CAMPBELL, Rory Gerald Peter
    Trowers & Hamlins
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    Administrateur
    Trowers & Hamlins
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    British94303270001
    CHILEMBA, Harneck
    112b Erlanger Road
    Telegraph Hill Park
    SE14 5TJ London
    Administrateur
    112b Erlanger Road
    Telegraph Hill Park
    SE14 5TJ London
    Malawian96356850001
    CLIFFORD, David Phillimore
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Administrateur
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish197049630001
    COOPER, Peter Harry
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Administrateur
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandBritish100351860001
    CRUTTENDEN, Peter
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Administrateur
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandBritish79421300001
    CUDD, John Charles
    4 Walnut Tree Walk
    BN20 9BP Eastbourne
    East Sussex
    Administrateur
    4 Walnut Tree Walk
    BN20 9BP Eastbourne
    East Sussex
    EnglandBritish113934990001
    DICKINSON MA, David John
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Administrateur
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish139132630001
    EVANS, Daniel
    Trowers & Hamlins
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    Administrateur
    Trowers & Hamlins
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    British94303280001
    FALCONER, Charles Leslie, Lord
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Administrateur
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish36324370001
    FARINA, Hilke
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Administrateur
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandIrish200319020001
    GIBB, Dominic
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Administrateur
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish187068870001
    HARLAND, Stuart
    Knellstone House
    Udimore
    TN31 6AR Rye
    East Sussex
    Administrateur
    Knellstone House
    Udimore
    TN31 6AR Rye
    East Sussex
    British114759590001
    HARRIOTT, Stephen
    6 Quay Court
    Westmeads Road
    CT5 1QZ Whitstable
    Kent
    Administrateur
    6 Quay Court
    Westmeads Road
    CT5 1QZ Whitstable
    Kent
    British113561590001
    HOLES, Eric
    2 Stable Courtyard
    Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    Administrateur
    2 Stable Courtyard
    Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    EnglandBritish90452390001
    INGRAM, Owen
    6 Arbor Close
    BR3 6TW Beckenham
    Kent
    Administrateur
    6 Arbor Close
    BR3 6TW Beckenham
    Kent
    United KingdomBritish103630530001
    KOTTEGODA, Siraj, Mr.
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Administrateur
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandBritish99206180001
    LEUNG, Stephen Sui Sang
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Administrateur
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish196161690001
    NEWSAM, Denise Feshina Philippa
    32 Garlies Road
    Forest Hill
    SE23 2RT London
    Administrateur
    32 Garlies Road
    Forest Hill
    SE23 2RT London
    United KingdomBritish96357030001
    OLASODE, Olusegun Ayodeji, Dr
    New Orchard House
    2a Monks Orchard Road, West Wickham
    BR3 3BW Beckenham
    Kent
    Administrateur
    New Orchard House
    2a Monks Orchard Road, West Wickham
    BR3 3BW Beckenham
    Kent
    United KingdomBritish52287010003
    OLIVER, David Henry Maxwell
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Administrateur
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish67052550001
    PANTER, Andrew
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Administrateur
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandBritish52734470001
    SMITH, Dennis Michael
    Treetops 57 Battery Hill
    Fairlight
    TN35 4AP Hastings
    East Sussex
    Administrateur
    Treetops 57 Battery Hill
    Fairlight
    TN35 4AP Hastings
    East Sussex
    United KingdomBritish69832870003
    SMITH, Sarah Anne
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Administrateur
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish127972360001
    STARKE, Christopher Charles
    35 Byng Road
    TN4 8EG Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    35 Byng Road
    TN4 8EG Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish62786710003
    WALKER, Stephen
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Administrateur
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    UkBritish113110240002
    WILCOX, Simon Stuart
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Administrateur
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandBritish198724310001
    WILSON, Ben
    Apartment 17 Tower 1
    416 Manchester Road
    E14 3RD London
    Administrateur
    Apartment 17 Tower 1
    416 Manchester Road
    E14 3RD London
    EnglandBritish90171030001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    04 déc. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed charge
    Créé le 06 janv. 2011
    Livré le 13 janv. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge all the chargor's rights title and interest from time to time in and to each of the following assets the facilities account and all moneys now or at any time in future standing to the credit of the facilities account see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transactions
    • 13 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 17 déc. 2010
    Livré le 22 déc. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first floating charge the whole of the chargor's undertaking and assets present and future all rights and claims to which the chargor is now or may hereafter become entitled in relation to all moneys now or at any time hereafter standing to the credit of the agf sinking fund together with all the rights relating of attaching hereto see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transactions
    • 22 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed charge
    Créé le 14 févr. 2007
    Livré le 02 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the right title and interest from time to time in and to each of the following assets, the facilities account and all rights and claims in relation to all moneys. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited (Security Trustee)
    Transactions
    • 02 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 26 mars 2004
    Livré le 15 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights and claims in relation to all moneys standing to the credit of the hgf sinking fund together with all rights relating or attaching thereto, all rights of the chargor under or in respect of the documents,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee on Behalf of the Beneficiaries
    Transactions
    • 15 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0