RBSSAF (13) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRBSSAF (13) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04985593
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RBSSAF (13) LIMITED ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe RBSSAF (13) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Quadrangle
    The Promenade
    GL50 1PX Cheltenham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de RBSSAF (13) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour RBSSAF (13) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour RBSSAF (13) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 déc. 2015

    État du capital au 23 déc. 2015

    • Capital: GBP 2
    • Capital: USD 100
    SH01

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    7 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    5 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    5 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    7 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 déc. 2014

    État du capital au 09 déc. 2014

    • Capital: GBP 2
    • Capital: USD 100
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    21 pagesAA

    Cessation de la nomination de Lambros Varnavides en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Sullivan en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 déc. 2013

    État du capital au 19 déc. 2013

    • Capital: GBP 2
    • Capital: USD 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Sharon Jill Caterer le 23 juin 2013

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    25 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Nomination de Rbs Secretarial Services Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Carolyn Down en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    26 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Miss Carolyn Jean Whittaker le 17 sept. 2011

    2 pagesCH03

    Nomination de Mr Paul Denzil John Sullivan en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    26 pagesAA

    Cessation de la nomination de Graham Locker en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de RBSSAF (13) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24-25
    Scotland
    Secrétaire
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24-25
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC269847
    169073830001
    CATERER, Sharon Jill
    The Promonade
    GL50 1PX Cheltenham
    The Quadrangle
    Gloucestershire
    England
    Administrateur
    The Promonade
    GL50 1PX Cheltenham
    The Quadrangle
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritish15490360001
    CHEESMAN, Philip Antony
    Great Tower Street
    EC3P 3HX London
    5-10
    England
    Administrateur
    Great Tower Street
    EC3P 3HX London
    5-10
    England
    EnglandBritish157812490001
    DOWN, Carolyn Jean
    280 Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    4th Floor
    England
    Secrétaire
    280 Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    4th Floor
    England
    Other67499700004
    THOMAS, Marina Louise
    Richmond Lodge
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    Secrétaire
    Richmond Lodge
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    British80901390001
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Administrateur
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    British98778780002
    CLEMETT, Graham Colin
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    Administrateur
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    United KingdomBritish123744930001
    DEVINE, Alan Sinclair
    42 Mirfield Road
    B91 1JD Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    42 Mirfield Road
    B91 1JD Solihull
    West Midlands
    British96634670001
    FARNELL, Adrian Colin
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish43015720002
    GEORGIOU, Andreas
    Little Hallingbury
    Bishops Stortford
    CM22 7RJ Herts
    The Lodge, Goose Lane
    England
    Administrateur
    Little Hallingbury
    Bishops Stortford
    CM22 7RJ Herts
    The Lodge, Goose Lane
    England
    British88113470002
    LATTER, William Vaughan
    Mernian
    Bushley
    GL20 6HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    Administrateur
    Mernian
    Bushley
    GL20 6HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    British52914600004
    LOCKER, Graham Richard
    Stratfirld Drive
    EN10 7NU Broxbourne
    19
    Hertfordshire
    Administrateur
    Stratfirld Drive
    EN10 7NU Broxbourne
    19
    Hertfordshire
    British132992690001
    PEARCE, Nigel
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    Administrateur
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    United KingdomBritish63084840002
    SLATTERY, Domhnal
    16 Ailesbury Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    Administrateur
    16 Ailesbury Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    Republic Of IrelandIrish154385180001
    SULLIVAN, Paul Denzil John
    Berberry Drivae
    MK45 5ER Flitton
    10
    Bedfordshire
    England
    Administrateur
    Berberry Drivae
    MK45 5ER Flitton
    10
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish111421900001
    TUBB, Philip Anthony
    15 Mardleybury Road
    SG3 6SG Datchworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    15 Mardleybury Road
    SG3 6SG Datchworth
    Hertfordshire
    British98115740001
    VARNAVIDES, Lambros
    Cedars
    24 Uphill Road Mill Hill
    NW7 4RB London
    Administrateur
    Cedars
    24 Uphill Road Mill Hill
    NW7 4RB London
    EnglandBritish33245340001

    RBSSAF (13) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of assignment
    Créé le 26 nov. 2004
    Livré le 03 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the assignor's right title and interest in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale, London Branch
    Transactions
    • 03 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A first priority bahamas mortgage
    Créé le 26 nov. 2004
    Livré le 03 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    64/64TH shares in the ship meaning the motor vessel "cma cgm vivaldi" with official number 8000839 together with all her boats guns ammunition small arms and appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale, London Branch
    Transactions
    • 03 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A deed of covenants
    Créé le 26 nov. 2004
    Livré le 03 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The ship meaning the motor vessel "cma cgm vivaldi" with official number 8000839 together with engines machinery boats tackle outfit fuels spares consumable and other stores belongings and appurtenances.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale, London Branch
    Transactions
    • 03 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Account security deed
    Créé le 29 oct. 2004
    Livré le 16 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The account balances and all other rights titles and interest of the head lessor in and to the lessor proceeds account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale, London Branch
    Transactions
    • 16 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0