ADMIRAL TAVERNS (RICKMANSWORTH) LIMITED

ADMIRAL TAVERNS (RICKMANSWORTH) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéADMIRAL TAVERNS (RICKMANSWORTH) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04992783
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ADMIRAL TAVERNS (RICKMANSWORTH) LIMITED ?

    • Restaurants avec licence (56101) / Hébergement et restauration
    • Débits de boissons et bars (56302) / Hébergement et restauration

    Où se situe ADMIRAL TAVERNS (RICKMANSWORTH) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ADMIRAL TAVERNS (RICKMANSWORTH) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ADMIRAL TAVERNS LIMITED19 mars 200419 mars 2004
    INHOCO 4015 LIMITED11 déc. 200311 déc. 2003

    Quels sont les derniers comptes de ADMIRAL TAVERNS (RICKMANSWORTH) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 mai 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour ADMIRAL TAVERNS (RICKMANSWORTH) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 mai 2018

    9 pagesLIQ03
    A7CXLSS2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13
    A7CXLSYH

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Admiral Taverns (Chester) Limited Milton Gate 60 Chiswell Street London EC1Y 4AG

    2 pagesAD03
    A6A0Z29E

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Milton Gate 60 Chiswell Street London EC1Y 4AG United Kingdom à Admiral Taverns (Chester) Limited Milton Gate 60 Chiswell Street London EC1Y 4AG

    2 pagesAD02
    A6A0Z269

    Changement d'adresse du siège social de 150 Aldersgate Street London EC1A 4EJ à 1 More London Place London SE1 2AF le 17 juil. 2017

    2 pagesAD01
    A6A0Z26H

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600
    A6A0Z26P

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01
    A6A0Z27D

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 mai 2017

    LRESSP

    Modification des coordonnées du secrétaire A G Secretarial Limited le 16 juin 2017

    1 pagesCH04
    X68P0A6I

    Satisfaction de la charge 049927830009 en totalité

    4 pagesMR04
    A683RWDN

    Déclaration de confirmation établie le 11 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01
    X5LUNX60

    Comptes annuels établis au 28 mai 2016

    17 pagesAA
    A5L24W0I

    Comptes annuels établis au 30 mai 2015

    15 pagesAA
    A4LQFLY8

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 déc. 2015

    État du capital au 14 déc. 2015

    • Capital: GBP 20
    SH01
    X4M9AKN5

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 déc. 2014

    État du capital au 18 déc. 2014

    • Capital: GBP 20
    SH01
    X3N0JGDF

    Comptes annuels établis au 31 mai 2014

    15 pagesAA
    A3LDU6PU

    Inscription de la charge 049927830009, créée le 09 oct. 2014

    82 pagesMR01
    A3ILONN7

    Satisfaction de la charge 049927830007 en totalité

    1 pagesMR04
    X37ZZJ6W

    Satisfaction de la charge 049927830008 en totalité

    1 pagesMR04
    X37XE61K

    Cessation de la nomination de Jonathan Paveley en tant que directeur

    2 pagesTM01
    L30QQHVE

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 déc. 2013

    État du capital au 16 déc. 2013

    • Capital: GBP 20
    SH01
    X2NCEVXU

    Comptes annuels établis au 01 juin 2013

    15 pagesAA
    A2L2O22X

    Statuts

    16 pagesMEM/ARTS
    R2CZ3TWB

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Financing arrangements 26/06/2013
    RES13
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de ADMIRAL TAVERNS (RICKMANSWORTH) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    A G SECRETARIAL LIMITED
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    Secrétaire
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    90084920001
    CLIFFORD, Andrew Francis James
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    Administrateur
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    EnglandBritishProperty Director119327230001
    GEORGEL, Kevin Roger
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    Administrateur
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    United KingdomBritishManaging Director153480970001
    PEARSON, Glenn
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    Administrateur
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant Cfo123243570001
    ROSENBERG, David
    5 Newlands Close
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    Secrétaire
    5 Newlands Close
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    BritishCompany Director2541410003
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    D'ARCY, Lynne
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director106840540001
    LANDESBERG, Alan
    Allingham Court
    44 The Bishops Avenue Hampstead
    N2 OBA London
    Flat 3,
    Administrateur
    Allingham Court
    44 The Bishops Avenue Hampstead
    N2 OBA London
    Flat 3,
    EnglandBritishCompany Director142883260001
    LANDESBERG, Gary Mitchell
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    Administrateur
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    United KingdomBritishDirector54137480002
    PAVELEY, Jonathan David, Dr
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    Cheshire
    Administrateur
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director100582600002
    PERCY, Andrew Graeme
    5 Carlton Avenue
    SK9 4EP Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    5 Carlton Avenue
    SK9 4EP Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director53017070002
    ROSENBERG, David
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director2541410004
    ROSENBERG, Elliot Simon
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director2541420006
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Administrateur désigné
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ADMIRAL TAVERNS (RICKMANSWORTH) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited Liability Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement07052594
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    ADMIRAL TAVERNS (RICKMANSWORTH) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 09 oct. 2014
    Livré le 16 oct. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 16 oct. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 juin 2013
    Livré le 12 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transactions
    • 12 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 juin 2013
    Livré le 09 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 09 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 17 nov. 2009
    Livré le 02 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC in Its Capacity as Security Trustee
    Transactions
    • 02 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 27 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 nov. 2009
    Livré le 02 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage the original property: and all estates or interests in f/h, l/h or commonhold property and which is owned by the chargor as at the date of the debenture, and in each case, all premises and fixtures on such property for the time being. By way of fixed charge all other estates or interests in f/h, l/h or commonhold property: the proceeds of sale of its secured property and all licences to enter on or use any secured property see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transactions
    • 02 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 27 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 30 janv. 2009
    Livré le 07 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 juil. 2007
    Livré le 04 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 04 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 juil. 2007
    Livré le 02 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 19 mars 2004
    Livré le 24 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as inhoco 4015 limited to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 24 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ADMIRAL TAVERNS (RICKMANSWORTH) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 mai 2017Commencement of winding up
    04 déc. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Colin Peter Dempster
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    practitioner
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Derek Hyslop
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    practitioner
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0