PENDLE RISE ESTATES LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPENDLE RISE ESTATES LTD
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05018826
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PENDLE RISE ESTATES LTD ?

    • (7012) /

    Où se situe PENDLE RISE ESTATES LTD ?

    Adresse du siège social
    Regional House 3rd Floor Someries Suite 28-34
    Chapel Street
    LU1 5BA Luton
    Bedfords
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PENDLE RISE ESTATES LTD ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 janv. 2007
    Date d'échéance des prochains comptes30 nov. 2007
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2006

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PENDLE RISE ESTATES LTD ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au19 janv. 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation02 févr. 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PENDLE RISE ESTATES LTD ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour PENDLE RISE ESTATES LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 18 avr. 2019

    2 pages3.6

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 mars 2019

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 sept. 2018

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 mars 2018

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 sept. 2017

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 mars 2017

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 sept. 2016

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 mars 2016

    2 pages3.6

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    legacy

    pagesLQ01

    legacy

    LQ01

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    legacy

    LQ01

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 02 nov. 2013

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 02 mai 2013

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 02 nov. 2012

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 02 mai 2012

    2 pages3.6

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    Avis d'achèvement de l'accord volontaire

    14 pages1.4

    legacy

    3 pagesLQ01

    Qui sont les dirigeants de PENDLE RISE ESTATES LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HUSSAIN, Mohammed
    21 Rowdon Avenue
    NW10 2AJ London
    Secrétaire
    21 Rowdon Avenue
    NW10 2AJ London
    BritishDirector76568270001
    MUNIR, Mohammed
    75 Evelyn Avenue
    Kingsbury
    NW9 0JF London
    Secrétaire
    75 Evelyn Avenue
    Kingsbury
    NW9 0JF London
    BritishConsultant72113420001
    HUSSAIN, Mohammed
    21 Rowdon Avenue
    NW10 2AJ London
    Administrateur
    21 Rowdon Avenue
    NW10 2AJ London
    United KingdomBritishDirector76568270001
    MUNIR, Mohammed
    75 Evelyn Avenue
    Kingsbury
    NW9 0JF London
    Administrateur
    75 Evelyn Avenue
    Kingsbury
    NW9 0JF London
    United KingdomBritishCompany Director72113420001
    RAJA, Bhupendra Karsandas
    71 Uphill Road
    NW7 4PT London
    Secrétaire
    71 Uphill Road
    NW7 4PT London
    BritishManaging Director70665390002
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Secrétaire désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    900015000001
    MUNIR, Mohammed
    75 Evelyn Avenue
    Kingsbury
    NW9 0JF London
    Administrateur
    75 Evelyn Avenue
    Kingsbury
    NW9 0JF London
    United KingdomBritishConsultant72113420001
    RAJA, Bhupendra Karsandas
    71 Uphill Road
    NW7 4PT London
    Administrateur
    71 Uphill Road
    NW7 4PT London
    EnglandBritishManaging Director70665390002
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Administrateur désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    900014990001

    PENDLE RISE ESTATES LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 01 oct. 2010
    Livré le 06 oct. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Shops 1 to 16 market hall the arndale centre hibson nelson t/no LA552262 and all buildings, structures, fixtures (including trade fixtures) & fixed plant & machinery & equipment from time to time thereon all right title & interest to, & in any proceeds of any present and future insurances of the property. Any present & future goodwill of the business (if any) & by way of floating charge, all moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture & equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 06 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 01 sept. 2010
    Livré le 02 sept. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a shops 1 to 16 market hall the arndale centre hibson street nelson t/no. LA552262 and all buildings, structures, fixtures (including trade fixtures) & fixed plant & machinery & equipment from time to time thereon all right title & interest to, & in any proceeds of any present and future insurances of the property. Any present & future goodwill of the business (if any) & by way of floating charge, all moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture & equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 02 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Charge
    Créé le 16 nov. 2006
    Livré le 18 nov. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All sums standing to the credit of the company in deposit account number 2633551 with bank of ireland.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 18 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of rental assignment
    Créé le 27 janv. 2006
    Livré le 28 janv. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Pendle rise shopping centre nelson t/nos LA737958, LA943662, LA738012 and LA738014 and all right title benefit and interest of the company in and to all rent, licence fees or other sums received by the company from any tenant or licensee of the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 28 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage deed
    Créé le 24 janv. 2006
    Livré le 28 janv. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Pendle rise shopping centre nelson t/nos LA737958, LA943662, LA738012 and LA738014 and fixed charge together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery.the benefit of all guarantees indemnities rent deposits.by way of assignment the goodwill of the business and all monies due in relation to contracts or policies of insurance.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 28 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 206 nov. 2010Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
    • 213 déc. 2014Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
    • 207 janv. 2015Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 417 mars 2015Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 219 mars 2015Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
    • 420 avr. 2019Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
    • 420 avr. 2019Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
      • Numéro de dossier 2
      • Numéro de dossier 4
    Rent deposit deed
    Créé le 04 avr. 2005
    Livré le 09 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    £1,350.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The deposited sum over the property.
    Personnes ayant droit
    • Network Rail Infrastructure Limited
    Transactions
    • 09 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 19 janv. 2005
    Livré le 22 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Pendle rise shopping centre t/ns LA552262 LA738012 LA737958 LA738014 and LA943662 the proceeds of sale and all buildings and trade and other fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag London
    Transactions
    • 22 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PENDLE RISE ESTATES LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 févr. 2010Date of meeting to approve CVA
    25 janv. 2011Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Michael Rose
    Silver House Silver Street
    DN1 1HL Doncaster
    practitioner
    Silver House Silver Street
    DN1 1HL Doncaster
    2Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Francis Creamer
    Kingsley House Wimpole Street
    W1G 0RE London
    receiver manager
    Kingsley House Wimpole Street
    W1G 0RE London
    Timothy Rolleston Gilbert Perkin
    Kingsley House Wimpole Street
    W1G 0RE London
    receiver manager
    Kingsley House Wimpole Street
    W1G 0RE London
    Richard James Stanley
    30 Warwick Street
    W1B 5NH London
    receiver manager
    30 Warwick Street
    W1B 5NH London
    Jemma Kathleen Mcandrew
    30 Warwick Street
    W1B 5NH London
    receiver manager
    30 Warwick Street
    W1B 5NH London
    Charlotte Rhoda Coates
    30 Warwick Street
    W1B 5NH London
    receiver manager
    30 Warwick Street
    W1B 5NH London
    3
    DateType
    19 avr. 2011Petition date
    14 juin 2011Commencement of winding up
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or St Albans
    1st Floor
    Trident House
    AL1 3HR 42-48 Victoria Street
    St Albans
    practitioner
    1st Floor
    Trident House
    AL1 3HR 42-48 Victoria Street
    St Albans
    4Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Marcus Benjamin Stone
    Clearwater House
    4-7 Manchester Street
    WU1 3AE London
    receiver manager
    Clearwater House
    4-7 Manchester Street
    WU1 3AE London
    Dana Genis
    Clearwater House
    4-7 Manchester Street
    WU1 3AE London
    receiver manager
    Clearwater House
    4-7 Manchester Street
    WU1 3AE London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0