KENMORE CAPITAL BOXMEER LIMITED

KENMORE CAPITAL BOXMEER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKENMORE CAPITAL BOXMEER LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05022807
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KENMORE CAPITAL BOXMEER LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe KENMORE CAPITAL BOXMEER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    26 Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KENMORE CAPITAL BOXMEER LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SOUTHMONT LIMITED22 janv. 200422 janv. 2004

    Quels sont les derniers comptes de KENMORE CAPITAL BOXMEER LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour KENMORE CAPITAL BOXMEER LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour KENMORE CAPITAL BOXMEER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 14 juin 2016

    3 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 07 janv. 2016

    3 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 08 janv. 2015

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Changement d'adresse du siège social de C/O Michelle Knott 28-29 Dover Street London W1S 4NA à 26 Red Lion Square London WC1R 4AG le 28 oct. 2014

    1 pagesAD01

    Nomination de Thierry Drinka en tant qu'administrateur le 22 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robert William Middleton Brook en tant que directeur le 22 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013

    3 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012

    3 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 avr. 2014

    État du capital au 04 avr. 2014

    • Capital: GBP 125,002
    SH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Tamar Capital Partners Limited 20 Hanover Square London W1S 1JY United Kingdom

    1 pagesAD02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Changement d'adresse du siège social de * Level 13 the Broadgate Tower Primrose Street London EC2A 2EW United Kingdom* le 17 déc. 2013

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Tamar Capital Partners Limited 271 Regent Street London W1B 2ES United Kingdom

    1 pagesAD02

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert William Middleton Brook le 02 févr. 2011

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de KENMORE CAPITAL BOXMEER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DRINKA, Thierry
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Administrateur
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    FranceFrenchDirector192167590001
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Secrétaire
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    BritishChartered Accountant462890002
    MCCALL, Peter Michael
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor119269620001
    BRIAN REID LTD.
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    Secrétaire désigné
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    900018660001
    BOTHWELL, Karen Margaret
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishBanker34800860003
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    BritishLawyer122926460001
    BROOK, Robert William Middleton
    c/o Michelle Knott
    Dover Street
    W1S 4NA London
    28-29
    England
    Administrateur
    c/o Michelle Knott
    Dover Street
    W1S 4NA London
    28-29
    England
    United KingdomBritishProperty Investment And Asset Manager154349100002
    BROOK, Robert William Middleton
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    Administrateur
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    United KingdomBritishChartered Surveyor59050120004
    KENNEDY, John Anthony Bingham
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    Administrateur
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritishChartered Surveyor71043680001
    WHITE, Andrew Edward
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritishChartered Surveyor110163980001
    STEPHEN MABBOTT LTD.
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Administrateur désigné
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    900018650001

    KENMORE CAPITAL BOXMEER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A charge over hedge documents
    Créé le 08 févr. 2007
    Livré le 23 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all right title and interest from time to time in and to the hedge documents to which it is a party and all proceeds paid or payable thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 26 oct. 2006
    Livré le 10 nov. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from an obligor or by some other person of each obligor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Aggrement and deed of creation of a first ranking right of mortgage
    Créé le 21 mai 2004
    Livré le 27 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the debtor, any of the guarantors or any of the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The plot of land with the buildings erected on it k/a 5831 ax boxmeer saxe gothastraat 4 registered with the eindhoven land regsitry as the municipality of boxmeer section l number 2242 and the plot of land with the buildings erected on it k/a 5831 ax boxmeer saxe gothastraat 6 registered with the eindhoven land regsitry as the municipality of boxmeer section l number 2007. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for Itself and for Thefinance Parties Under the Security Trust Deed) (the Security Trustee)
    Transactions
    • 27 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 avr. 2004
    Livré le 11 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and for Thefinance Parties Under the Security Trust Deed (The Security Trustee)
    Transactions
    • 11 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 21 avr. 2004
    Livré le 11 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A floating charge over the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and for Thefinance Parties Under the Security Trust Deed (The Security Trustee)
    Transactions
    • 11 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    KENMORE CAPITAL BOXMEER LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 janv. 2015Commencement of winding up
    27 sept. 2016Due to be dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Eileen Blackburn
    56 Palmerston Place
    EH12 5AY Edinburgh
    practitioner
    56 Palmerston Place
    EH12 5AY Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0