CSL INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCSL INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05034304
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CSL INVESTMENTS LIMITED ?

    • Autres industries manufacturières n.d.a. (32990) / Industries manufacturières

    Où se situe CSL INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Salamander Quay West
    Park Lane
    UB9 6NZ Harefield
    Middlesex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CSL INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour CSL INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré First Floor Templeback 10 Temple Back Bristol BS1 6FL

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à First Floor Templeback 10 Temple Back Bristol BS1 6FL

    1 pagesAD02

    Modification des coordonnées du secrétaire Jordan Cosec Limited le 05 avr. 2019

    1 pagesCH04

    Satisfaction de la charge 050343040007 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 04 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Jordan Cosec Limited en tant que secrétaire le 15 oct. 2018

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Simon James Banks en tant que secrétaire le 15 oct. 2018

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Thomas William Elliott Leigh en tant qu'administrateur le 15 oct. 2018

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Edward Heale en tant qu'administrateur le 20 juil. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Didier Faure en tant que directeur le 20 juin 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 04 févr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de David John Doble en tant que directeur le 02 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Didier Faure en tant qu'administrateur le 01 sept. 2017

    2 pagesAP01

    Statuts

    14 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Inscription de la charge 050343040007, créée le 10 févr. 2017

    57 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 04 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    6 pagesAA

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    5 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 févr. 2016

    État du capital au 09 févr. 2016

    • Capital: GBP 950,144
    SH01

    Qui sont les dirigeants de CSL INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VISTRA COSEC LIMITED
    Templeback
    10 Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    First Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    Templeback
    10 Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    First Floor
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement06412777
    128256230002
    BANKS, Simon James
    Salamander Quay West
    Park Lane
    UB9 6NZ Harefield
    Middlesex
    Administrateur
    Salamander Quay West
    Park Lane
    UB9 6NZ Harefield
    Middlesex
    United KingdomBritish50494840002
    HEALE, Edward Christopher Fairfax
    Salamander Quay West
    Park Lane
    UB9 6NZ Harefield
    Middlesex
    Administrateur
    Salamander Quay West
    Park Lane
    UB9 6NZ Harefield
    Middlesex
    United KingdomBritish212723740001
    HOLLETT, Philip Stevenson
    Salamander Quay West
    Park Lane
    UB9 6NZ Harefield
    Middlesex
    Administrateur
    Salamander Quay West
    Park Lane
    UB9 6NZ Harefield
    Middlesex
    EnglandBritish107810650008
    LEIGH, Thomas William Elliott
    Park Lane
    Harefield
    UB9 6NZ Uxbridge
    Salamander Quay West
    Middlesex
    United Kingdom
    Administrateur
    Park Lane
    Harefield
    UB9 6NZ Uxbridge
    Salamander Quay West
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandBritish263289450001
    BANKS, Simon James
    Salamander Quay West
    Park Lane
    UB9 6NZ Harefield
    Middlesex
    Secrétaire
    Salamander Quay West
    Park Lane
    UB9 6NZ Harefield
    Middlesex
    British50494840002
    COLGAN, Thomas Martin
    7 Cedar Drive
    Hatch End
    HA5 4DD Pinner
    Middx
    Secrétaire
    7 Cedar Drive
    Hatch End
    HA5 4DD Pinner
    Middx
    British74168960002
    ALDBURY SECRETARIES LIMITED
    Ternion Court
    264-268 Upper Fourth Street
    MK9 1DP Central Milton Keynes
    Bucks
    Secrétaire désigné
    Ternion Court
    264-268 Upper Fourth Street
    MK9 1DP Central Milton Keynes
    Bucks
    900018420001
    BROOKES, Christopher
    10 Highlands
    Farnham Common
    SL2 3JR Slough
    Berkshire
    Administrateur
    10 Highlands
    Farnham Common
    SL2 3JR Slough
    Berkshire
    United KingdomBritish16102860002
    COLGAN, Thomas Martin
    7 Cedar Drive
    Hatch End
    HA5 4DD Pinner
    Middx
    Administrateur
    7 Cedar Drive
    Hatch End
    HA5 4DD Pinner
    Middx
    United KingdomBritish74168960002
    DOBLE, David John
    Salamander Quay West
    Park Lane
    UB9 6NZ Harefield
    Middlesex
    Administrateur
    Salamander Quay West
    Park Lane
    UB9 6NZ Harefield
    Middlesex
    EnglandBritish86978140001
    FAURE, Didier Joseph Andre
    Salamander Quay West
    Park Lane
    UB9 6NZ Harefield
    Middlesex
    Administrateur
    Salamander Quay West
    Park Lane
    UB9 6NZ Harefield
    Middlesex
    EnglandBritish87482730002
    FINCH, Robert Anthony
    108 High Street
    Kimpton
    SG4 8QP Hitchin
    Hertfordshire
    Administrateur
    108 High Street
    Kimpton
    SG4 8QP Hitchin
    Hertfordshire
    British12035980001
    HAWKER, Michael James
    Manor Croft 45 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9AX Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Manor Croft 45 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9AX Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish10686160001
    ALDBURY DIRECTORS LIMITED
    Ternion Court
    264-268 Upper Fourth Street
    MK9 1DP Central Milton Keynes
    Bucks
    Administrateur désigné
    Ternion Court
    264-268 Upper Fourth Street
    MK9 1DP Central Milton Keynes
    Bucks
    900018410001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CSL INVESTMENTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Dualcom Holdings Limited
    Park Lane
    UB9 6NZ Harefield
    Salamander Quay West
    Middlesex
    England
    06 avr. 2016
    Park Lane
    UB9 6NZ Harefield
    Salamander Quay West
    Middlesex
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUk
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales Company Registry
    Numéro d'enregistrement05758908
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    CSL INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 10 févr. 2017
    Livré le 13 févr. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Not applicable.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties (Security Agent)
    Transactions
    • 13 févr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 22 mars 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 23 déc. 2011
    Livré le 30 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Octopus Investments Limited (The Trustee)
    Transactions
    • 30 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 sept. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession
    Créé le 22 mars 2011
    Livré le 07 avr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from or by any charging company to the security beneficiaries (or any of them) or to the trustee on any account under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Octopus Asset Management Limited (The Trustee)
    Transactions
    • 07 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of accession
    Créé le 22 mars 2011
    Livré le 05 avr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) or the trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The loan agreement dated the same date as this deed made between the borrower the trustee and the lenders party to such loan agreement which for the purposes of the guarantee and debenture replaces the loan agreement originally defined in the guarantee and debenture see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Octopus Investments Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 05 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 06 févr. 2009
    Livré le 23 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Octopus Investments Limited (The Trustee)
    Transactions
    • 23 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 12 juin 2006
    Livré le 20 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries or to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Octopus Asset Management Limited (As Security Trustee)
    Transactions
    • 20 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 12 juin 2006
    Livré le 16 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Singer & Friedlander Limited
    Transactions
    • 16 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0