CBRAIL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCBRAIL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05050256
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CBRAIL LIMITED ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe CBRAIL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CBRAIL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CBRAIL LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CBRAIL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pages4.71

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN United Kingdom à Level 7 Bishopsgate Exchange 155 Bishopsgate London EC2M 3YB

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Level 7 Bishopsgate Exchange 155 Bishopsgate London EC2M 3YB à 1 More London Place London SE1 2AF le 19 déc. 2014

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 28 nov. 2014

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Nomination de Lloyds Secretaries Limited en tant que secrétaire le 13 nov. 2014

    2 pagesAP04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 févr. 2014

    État du capital au 19 févr. 2014

    • Capital: EUR 500,000
    • Capital: GBP 1
    SH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    18 pagesAA

    Cessation de la nomination de Gavin White en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neil Dewar Lewis le 23 janv. 2013

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Colin Graham Dowsett en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Timothy Durham en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    17 pagesAA

    Nomination de Mr Neil Dewar Lewis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Gavin White le 07 mars 2012

    1 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    6 pagesMG02

    Qui sont les dirigeants de CBRAIL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LLOYDS SECRETARIES LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement02791894
    73512200003
    DOWSETT, Colin Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant152332230001
    LEWIS, Neil Dewar
    10 Old Burlington Street
    W1S 3AG London
    C/O Lw2
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Old Burlington Street
    W1S 3AG London
    C/O Lw2
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector103229440001
    DOWNS, Steven George
    Scarecrows
    66 Leas Road
    CR6 9LL Warlingham
    Surrey
    Secrétaire
    Scarecrows
    66 Leas Road
    CR6 9LL Warlingham
    Surrey
    British16641880002
    GITTINS, Paul
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Secrétaire
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    British45660860003
    LODGE, Matthew Sebastian
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    British32609030001
    WHITE, Gavin Raymond
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    165229200001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DAVY, Philip Maturin
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    Administrateur
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    EnglandBritishBanker96202910001
    DAVY, Philip Maturin
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    Administrateur
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    EnglandBritishBanking96202910001
    DUNCAN, Timothy
    Ellerslie House
    The Glade
    KT20 6LL Kingswood
    Surrey
    Administrateur
    Ellerslie House
    The Glade
    KT20 6LL Kingswood
    Surrey
    United KingdomBritishLawyer104005710001
    DURHAM, Timothy Sebastian
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomBritishHead Of Rail Capital152682880001
    GOOSEN, Willem
    Vogelsangstrasse 6
    Grunwald
    82031
    Germany
    Administrateur
    Vogelsangstrasse 6
    Grunwald
    82031
    Germany
    DutchCommercial Director104881570002
    LEWIS, Neil Dewar
    15th Floor
    5 Aldermanbury Square
    EC2V 7HR London
    Babcock & Brown International Group
    Administrateur
    15th Floor
    5 Aldermanbury Square
    EC2V 7HR London
    Babcock & Brown International Group
    United KingdomBritishLawyer/Director103229440001
    MARR, Graham Peter Wilson
    Mole Rise
    15 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Mole Rise
    15 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    EnglandBritishBanker69564800002
    MORE, Gordon Lennie Truman
    20 Dollarbeg Park
    FK14 7LJ Dollar
    Clackmannanshire
    Administrateur
    20 Dollarbeg Park
    FK14 7LJ Dollar
    Clackmannanshire
    United KingdomScottishBanker111414890002
    MORRISSEY, John Michael
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    Administrateur
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    EnglandBritishChartered Accountant94094650001
    PETERS, Stephen John
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    Administrateur
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    BritishBanker56296720007
    PETERS, Stephen John
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    Administrateur
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    BritishFinancial Controller56296720007
    REID, George Gibson
    46/1 Morningside Park
    EH10 5HA Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    46/1 Morningside Park
    EH10 5HA Edinburgh
    Lothian
    BritishAccountant95498730001
    SHINDLER, David Lawrence
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant92235400001
    SHINDLER, David Lawrence
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant92235400001
    TOWN, Lindsay John
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritishHead Of Structured Asset Finan64287260001
    WALSH, Kenton
    Winter House
    83 Hedgerley Lane
    HP9 2JS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Winter House
    83 Hedgerley Lane
    HP9 2JS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishBanker125918020001
    WILSON, Edward Arthur
    Flat 3 28 Folgate Street
    E1 6BX London
    Administrateur
    Flat 3 28 Folgate Street
    E1 6BX London
    United KingdomBritishBanker214718430001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    CBRAIL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over shares
    Créé le 07 avr. 2006
    Livré le 26 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge in and to all of the secured property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 26 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over shares
    Créé le 29 mars 2006
    Livré le 06 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the shares and all stock shares warrents securities rights moneys and property (including the dividends interest or income thereon or wherefrom). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited as Security Trustee for and on Behalf of Thebank and Any Other Lenders from Time to Time
    Transactions
    • 06 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A charge over shares
    Créé le 21 déc. 2005
    Livré le 23 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from cbrail (nordarz) limited to the bank or the chargee on any accountw hatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights title and interest in and to the shares and all stock shares warrants securities rights moneys or property (including dividends interest or income). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited as Security Trustee for and on Behalf of Thebank and Any Other Lenders
    Transactions
    • 23 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over shares
    Créé le 27 oct. 2005
    Livré le 07 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from cbrail (ruhr-sieg) limited to the chargee or the bank on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the rights, title and interest in and to the shares (including the dividends). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited, as Security Trustee for and on Behalf of Thebank and Any Other Lenders from Time to Time
    Transactions
    • 07 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over shares
    Créé le 13 janv. 2005
    Livré le 28 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The secured property being the shares and all stock, shares warrants, including the dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited as Security Trustee for and on Behalf of Thebank and Any Other Lenders from Time to Time
    Transactions
    • 28 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A charge over shares
    Créé le 12 nov. 2004
    Livré le 19 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The secured property being the shares and all stock, shares warrants, including the dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited as Security Trustee for and on Behalf of Thebank and Any Other Lenders from Time to Time
    Transactions
    • 19 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    CBRAIL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 avr. 2016Dissolved on
    28 nov. 2014Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Elizabeth Anne Bingham
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0