GUILDCARE (CAMPDEN) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GUILDCARE (CAMPDEN) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 05068857 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GUILDCARE (CAMPDEN) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 2nd Floor Asticus Building 21 Palmer Street SW1H 0AD London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GUILDCARE (CAMPDEN) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour GUILDCARE (CAMPDEN) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 mars 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 mars 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 10 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Sanne Group Secretaries (Uk) Limited le 20 juil. 2015 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 2 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Sanne Group Pollen House 10/12 Cork Street London W1S 3NP à 2nd Floor Asticus Building 21 Palmer Street London SW1H 0AD le 05 août 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 10 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Jonathan David Farkas en tant qu'administrateur le 27 janv. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mathieu Streiff en tant que directeur le 27 janv. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
legacy | 28 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE1 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 10 mars 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * C/O Sanne Group 2Nd Floor Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP* le 08 avr. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mathieu Streiff le 31 mars 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Sanne Group Secretaries (Uk) Limited le 31 mars 2014 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * C/O Sanne Group 1 Berkeley Street London United Kingdom W1J 8DJ* le 07 avr. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2014 au 31 déc. 2013 | 3 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013 | 9 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GUILDCARE (CAMPDEN) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED | Secrétaire | Palmer Street SW1H 0AD London 21 England |
| 175738460001 | ||||||||||
| FARKAS, Jonathan David | Administrateur | 21 Palmer Street SW1H 0AD London 2nd Floor Asticus Building | Luxembourg | American | 193539990001 | |||||||||
| PRICE, Jennifer | Secrétaire | Harrow House Lower High Street GL55 6DY Chipping Campden Gloucestershire | British | 51570420001 | ||||||||||
| SCHOFIELD, Nigel Bennett | Secrétaire | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | British | 52338530002 | ||||||||||
| CORMACK, Derek George | Administrateur | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | England | Irish | 67400530015 | |||||||||
| HILL, Peter Martin | Administrateur | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | England | British | 130983750001 | |||||||||
| JEFFERY, Paul Anthony Keith | Administrateur | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | United Kingdom | British | 65609290003 | |||||||||
| PRICE, Gareth | Administrateur | 27 Railway Crescent CV36 4GD Shipston On Stour Warwickshire | England | British | 62073810002 | |||||||||
| PRICE, Jennifer | Administrateur | Harrow House Lower High Street GL55 6DY Chipping Campden Gloucestershire | England | British | 51570420001 | |||||||||
| PRICE, Trevor | Administrateur | Harrow House Lower High Street GL55 6DY Chipping Campden Gloucestershire | England | British | 51570510001 | |||||||||
| SANDHU, Shahid Hussain Khan, Dr | Administrateur | 81 Ingestre Road B28 9EQ Birmingham | England | British | 57227020001 | |||||||||
| SCHOFIELD, Nigel Bennett | Administrateur | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | United Kingdom | British | 148139420001 | |||||||||
| STREIFF, Mathieu Bernard | Administrateur | 10/12 Cork Street W1S 3NP London Pollen House England | United States | American | 200529310001 | |||||||||
| WHITE, Ian James | Administrateur | Wetherden Road Haughley Haughley Green IP14 3RE Stowmarket Wetherden Cottage Suffolk United Kingdom | England | British | 133383410003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GUILDCARE (CAMPDEN) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga Hc Reit Ch Uk Senior Housing Portfolio Limited | 06 avr. 2016 | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building, 2nd Floor England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
GUILDCARE (CAMPDEN) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 28 juil. 2010 Livré le 06 août 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A deed of accession | Créé le 20 nov. 2007 Livré le 29 nov. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed charge all plant and machinery all rental and other income all derivative rights goodwill uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignment of building contract | Créé le 04 oct. 2006 Livré le 06 oct. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All rights title benefit and interest in the assigned documents meaning the agreement and all collateral instruments arising there from and all claims rights payments and remedies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 14 juin 2006 Livré le 20 juin 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a the guild sheep street chiping campden gloucestershire t/no GR291645 and GR294117. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 04 mai 2006 Livré le 10 mai 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0