HUB WHOLESALE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHUB WHOLESALE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05071309
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HUB WHOLESALE LIMITED ?

    • (5134) /
    • (5137) /
    • (5138) /
    • (5143) /

    Où se situe HUB WHOLESALE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Equity House
    Inthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de HUB WHOLESALE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour HUB WHOLESALE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 mars 2011

    État du capital au 17 mars 2011

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Charles Wilson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Laura Taylor en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Laura Taylor en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Jonathan Prentis en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark Chilton en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jonathan Paul Prentis le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mark Chilton le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Comptes établis au 31 mars 2009

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 mars 2008

    4 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    11 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de HUB WHOLESALE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TAYLOR, Laura
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    Secrétaire
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    155916610001
    TAYLOR, Laura
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    Administrateur
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    United KingdomBritish155913200001
    CHILTON, Mark
    Equity House
    Inthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Equity House
    Inthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    British109675640001
    DREW, Bryan John Charles
    129 Scotland Road
    LE16 8AY Market Harborough
    Leicestershire
    Secrétaire
    129 Scotland Road
    LE16 8AY Market Harborough
    Leicestershire
    British99726110002
    PRENTIS, Jonathan Paul
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    Secrétaire
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    British48949090001
    WOODBURN, Paul
    104 Chain House Lane
    Whitestake
    PR4 4LB Preston
    Lancashire
    Secrétaire
    104 Chain House Lane
    Whitestake
    PR4 4LB Preston
    Lancashire
    British77798070001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BOWEN, Richard William
    Blackbridge
    NN12 8DR Towcester
    Northamptonshire
    Administrateur
    Blackbridge
    NN12 8DR Towcester
    Northamptonshire
    United KingdomBritish151921790001
    COWARD, Mervyn Roderic
    The Lindens
    Nooklands Fulwood
    PR2 8XN Preston
    Lancashire
    Administrateur
    The Lindens
    Nooklands Fulwood
    PR2 8XN Preston
    Lancashire
    EnglandBritish2391210002
    DREW, Bryan John Charles
    129 Scotland Road
    LE16 8AY Market Harborough
    Leicestershire
    Administrateur
    129 Scotland Road
    LE16 8AY Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish99726110002
    HUSTAD, Hans Kristian
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    Administrateur
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    Norwegian103594230001
    JOHAL, Markham Singh
    C/O Bull Close Road
    Lenton Ind Estate
    NG7 2UT Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    C/O Bull Close Road
    Lenton Ind Estate
    NG7 2UT Nottingham
    Nottinghamshire
    British101862180001
    JOHANNESSON, Jon Asgeir
    Laufasvegur 69
    FOREIGN Reykjavik
    101
    Iceland
    Administrateur
    Laufasvegur 69
    FOREIGN Reykjavik
    101
    Iceland
    IcelandIcelandic78382920001
    OVERTON, Antony John
    21 Manor Avenue
    CW2 8BD Wistaston
    Cheshire
    Administrateur
    21 Manor Avenue
    CW2 8BD Wistaston
    Cheshire
    British82484430001
    PRENTIS, Jonathan Paul
    Equity House
    Inthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    Administrateur
    Equity House
    Inthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    United KingdomBritish48949090001
    SIGURDSSON, Gunnar
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    Administrateur
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    EnglandIcelandic114179720001
    WILSON, Charles
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northants
    Administrateur
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northants
    United KingdomBritish123998480001
    WILSON, John Shearer
    Flat 6 Dyrham Park
    SN14 8ER Dyrham
    Wilts
    Administrateur
    Flat 6 Dyrham Park
    SN14 8ER Dyrham
    Wilts
    GbrBritish55636090004
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    HUB WHOLESALE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of accession to the debenture
    Créé le 28 oct. 2005
    Livré le 05 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company (or any of them) to the security trustee and/or the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Trustee)Th
    Transactions
    • 05 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0