KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED

KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05079880
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    10 Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KIRKMERE LIMITED22 mars 200422 mars 2004

    Quels sont les derniers comptes de KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 juil. 2018

    10 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de 26 Red Lion Square London WC1R 4AG à 10 Queen Street Place London EC4R 1AG le 19 déc. 2017

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Charles Ebbrell le 17 juil. 2017

    2 pagesCH01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 03 juil. 2017

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Thierry Drinka en tant que directeur le 23 mai 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 22 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 avr. 2016

    État du capital au 05 avr. 2016

    • Capital: GBP 725,002
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Charles Ebbrell le 09 sept. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    3 pagesAA

    Inscription de la charge 050798800013, créée le 05 mai 2015

    59 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 avr. 2015

    État du capital au 08 avr. 2015

    • Capital: GBP 725,002
    SH01

    Inscription de la charge 050798800012, créée le 12 mars 2015

    64 pagesMR01

    Inscription de la charge 050798800011, créée le 12 mars 2015

    45 pagesMR01

    Inscription de la charge 050798800010, créée le 27 févr. 2015

    48 pagesMR01

    Nomination de David Charles Ebbrell en tant qu'administrateur le 18 déc. 2014

    2 pagesAP01

    legacy

    MG01

    Inscription d'une charge

    MR01

    Inscription de la charge 050798800008, créée le 22 déc. 2014

    32 pagesMR01

    Inscription de la charge 050798800009, créée le 22 déc. 2014

    32 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    14 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EBBRELL, David Charles
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish142799490002
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Secrétaire
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    British462890002
    MCCALL, Peter Michael
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    British119269620001
    BRIAN REID LTD.
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    Secrétaire désigné
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    900018660001
    BOTHWELL, Karen Margaret
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish34800860003
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    British122926460001
    BROOK, Robert William Middleton
    c/o Michelle Knott
    Dover Street
    W1S 4NA London
    28-29
    England
    Administrateur
    c/o Michelle Knott
    Dover Street
    W1S 4NA London
    28-29
    England
    United KingdomBritish149783170001
    BROOK, Robert William Middleton
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    Administrateur
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    United KingdomBritish59050120004
    DRINKA, Thierry
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Administrateur
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    FranceFrench192167590001
    KENNEDY, John Anthony Bingham
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    Administrateur
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritish71043680001
    WHITE, Andrew Edward
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritish110163980001
    STEPHEN MABBOTT LTD.
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Administrateur désigné
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    900018650001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    22 mars 2017La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société.

    KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 05 mai 2015
    Livré le 14 mai 2015
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Situs Asset Management Limited
    Transactions
    • 14 mai 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 12 mars 2015
    Livré le 24 mars 2015
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Situs Asset Management Limited
    Transactions
    • 24 mars 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 12 mars 2015
    Livré le 24 mars 2015
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Situs Asset Management Limited (The Security Agent)
    Transactions
    • 24 mars 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 27 févr. 2015
    Livré le 17 mars 2015
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Situs Asset Management Limited (The Pledgee)
    Transactions
    • 17 mars 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 22 déc. 2014
    Livré le 31 déc. 2014
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Situs Asset Managment Limited (The Security Agent)
    Transactions
    • 31 déc. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 22 déc. 2014
    Livré le 31 déc. 2014
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Situs Asset Management Limited (The Security Agent)
    Transactions
    • 31 déc. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    Insurance receivables security agreement
    Créé le 17 déc. 2010
    Livré le 29 déc. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of its rights under any contract of insurance and all monies paid under or in respect of all such contracts of insurance see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 29 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 30 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A security agreement
    Créé le 17 déc. 2010
    Livré le 29 déc. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 29 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 30 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A charge over hedge documents
    Créé le 08 févr. 2007
    Livré le 23 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all right title and interest from time to time in and to the hedge documents to which it is a party and all proceeds paid or payable thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 26 oct. 2006
    Livré le 10 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from an obligor or by some other person of each obligor to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Aggrement and deed of creation of a first ranking right of mortgage
    Créé le 21 mai 2004
    Livré le 27 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the debtor, any of the guarantors or any of the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The plot of land with the buildings erected on it k/a 8171 mc vaassen runnenbergweg 12 registered with the arnhem land registry as the municipality of vaassen section h number 3358, the plot of land with the buildings on it k/a 8171 mb vaassen talhoutweg 2 registered with the arnhem land registry as the municipality of vaassen section h number 3533 and the part plot of land with the buildings erected on it k/a 8171 mc vaassen runnenbergweg 10 registered with the arnhem land registry as the municipality of vaassen section h number 3148. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for Itself and for Thefinance Parties Under the Security Trust Deed) (the Security Trustee)
    Transactions
    • 27 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 avr. 2004
    Livré le 11 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and for Thefinance Parties Under the Security Trust Deed (The Security Trustee)
    Transactions
    • 11 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 21 avr. 2004
    Livré le 11 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A floating charge over the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and for Thefinance Parties Under the Security Trust Deed (The Security Trustee)
    Transactions
    • 11 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 juil. 2017Commencement of winding up
    25 avr. 2019Due to be dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Gardiner
    3 Castle Court Carnegie Campus
    KY11 8PB Dunfermline
    practitioner
    3 Castle Court Carnegie Campus
    KY11 8PB Dunfermline

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0