PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED

PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05081105
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ONE ONE ONE LIMITED15 déc. 200415 déc. 2004
    PROTECTAGROUP LIMITED03 nov. 200403 nov. 2004
    ONE ONE ONE LIMITED23 mars 200423 mars 2004

    Quels sont les derniers comptes de PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 23 mars 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Dean Clarke en tant que secrétaire le 22 févr. 2022

    1 pagesTM02

    Nomination de Ardonagh Corporate Secretary Limited en tant que secrétaire le 22 févr. 2022

    2 pagesAP04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 mars 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 16 déc. 2020

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium of £1628000 be reduced to nil - credited to retained reserves 01/12/2020
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    4 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 1 Minster Court London EC3R 7AA United Kingdom à 2 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7PD le 14 juil. 2020

    1 pagesAD01

    Modification des détails de Protectagroup Acquisitions Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 juil. 2020

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 23 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Protectagroup Acquisitions Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 juil. 2019

    2 pagesPSC05

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    20 pagesAA

    Cessation de la nomination de Antonios Erotocritou en tant que directeur le 01 août 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Diane Cougill en tant qu'administrateur le 01 août 2019

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Tower Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN à 1 Minster Court London EC3R 7AA le 30 juil. 2019

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 23 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 050811050009 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ARDONAGH CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Secrétaire
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement03702575
    288842300001
    COUGILL, Diane
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Administrateur
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Finance Officer158614590002
    ROSS, David Christopher
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Administrateur
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    EnglandIrishDirector222326970001
    BROWN, Ian William
    36 Beech Wood Drive
    Tonyrefail
    CF39 8JE Rhondda Cynon Taff
    Mid Glamorgan
    Secrétaire
    36 Beech Wood Drive
    Tonyrefail
    CF39 8JE Rhondda Cynon Taff
    Mid Glamorgan
    BritishDirector262382040001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Secrétaire
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    British117669700002
    CLARKE, Dean
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Secrétaire
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    253939990001
    GOURIET, Geoffrey Costerton
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Secrétaire
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    249087180001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Secrétaire
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    221972880001
    KIRKNESS, Barrie
    76 Glan Y Ffordd
    CF15 7SL Taffs Well
    South Glamorgan
    Secrétaire
    76 Glan Y Ffordd
    CF15 7SL Taffs Well
    South Glamorgan
    British103733180001
    OWENS, Jennifer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Secrétaire
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    183326340001
    RAGAN, Sharon Marie
    Old Tregyrnog Farmhouse
    St Brides Super Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Secrétaire
    Old Tregyrnog Farmhouse
    St Brides Super Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    BritishInsurance Broker67745500003
    KTS SECRETARIES LIMITED
    The Counting House
    Dunleavy Drive
    CF11 0SN Cardiff
    Secrétaire
    The Counting House
    Dunleavy Drive
    CF11 0SN Cardiff
    84474590001
    BARR, Graham Maxwell
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector125097020001
    BRICE, Ian Charles
    Sycamore Cottage
    Bonvilston
    CF5 6TR Cardiff
    South Glamorgan
    Administrateur
    Sycamore Cottage
    Bonvilston
    CF5 6TR Cardiff
    South Glamorgan
    BritishChairman63706880001
    BROWN, Ian William
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishCompliance Director262382040001
    BROWN, Roger Michael
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    Administrateur
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    EnglandBritishCompany Director134140540001
    BRUCE, David James
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector171398800001
    CHARD, Michael Francis
    23 Knightsbridge Court
    CH1 1QG Chester
    Administrateur
    23 Knightsbridge Court
    CH1 1QG Chester
    UkBritishChairman45725420009
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector149939610001
    EGAN, Scott
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector170703910001
    EROTOCRITOU, Antonios
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    United KingdomCypriotDeputy Cfo167795710001
    EVANS, Ieuan Cennydd
    Ysgubor Goch
    Llandough
    CF71 7LR Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    Administrateur
    Ysgubor Goch
    Llandough
    CF71 7LR Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    WalesBritishDirector66329000004
    HAGGETT, Linda
    Graig Y Mynydd
    CF39 8FD Thomastown
    51
    Tonyrefail
    Administrateur
    Graig Y Mynydd
    CF39 8FD Thomastown
    51
    Tonyrefail
    United KingdomWelshInsurance Broker137893590001
    HODGES, Mark Steven
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector58444370003
    JOHNSON, Timothy David
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    Administrateur
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    EnglandBritishCompany Director129538180001
    LYONS, Alastair David
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    EnglandBritishExecutive Chairman193700540001
    MUGGE, Mark Stephen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    EnglandBritishDirector162920630005
    PARK, Bryan
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector113694470002
    POWELL, Kenneth John
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    WalesBritishDirector27317930001
    RAGAN, Paul Robert
    Tregyrnog Farmhouse
    St. Brides-Super-Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Vale Of Glamorgan
    Administrateur
    Tregyrnog Farmhouse
    St. Brides-Super-Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Vale Of Glamorgan
    United KingdomBritishManaging Director60263070005
    REA, Michael Peter
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector147194830001
    RIDEWOOD, Gary Spencer
    Leigh Cottage
    Mount Road
    CF64 4DG Dinas Powys
    South Glamorgan
    Administrateur
    Leigh Cottage
    Mount Road
    CF64 4DG Dinas Powys
    South Glamorgan
    WalesBritishFinance Director112745560001
    WIGLEY, William George
    46 Heol St Cattwg
    Pendoylan
    CF71 7UG Cowbridge
    South Glamorgan
    Administrateur
    46 Heol St Cattwg
    Pendoylan
    CF71 7UG Cowbridge
    South Glamorgan
    WalesBritishDirector193333870002
    KTS NOMINEES LIMITED
    The Counting House
    Dunleavy Drive
    CF11 0SN Cardiff
    Administrateur
    The Counting House
    Dunleavy Drive
    CF11 0SN Cardiff
    84474580001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Protectagroup Acquisitions Limited
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueCompany Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House Cardiff
    Numéro d'enregistrement06512090
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 02 avr. 2015
    Livré le 22 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    By way of first legal mortgage all legal interest in trademark registration/application number 2413912 as listed in schedule 5 (intellectual property) of the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Bank of New York Mellon, London Branch
    Transactions
    • 22 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 18 févr. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 10 mai 2013
    Livré le 23 mai 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Pursuant to clause 3.1(b)(vii) of the charge, the company charged by way of first fixed charge all its intellectual property, including the following:. Trademark registration/application number 2413912.. pursuant to the charge, the company charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 23 mai 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security accession deed
    Créé le 27 juin 2012
    Livré le 07 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Security Agent)
    Transactions
    • 07 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 23 sept. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 27 juin 2012
    Livré le 06 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    Transactions
    • 06 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 23 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 sept. 2010
    Livré le 18 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 18 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of accession
    Créé le 04 juin 2008
    Livré le 17 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 17 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 26 sept. 2006
    Livré le 04 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 oct. 2004
    Livré le 20 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 06 oct. 2004
    Livré le 21 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0