STREET NORTH EAST LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | STREET NORTH EAST LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
| Numéro de société | 05086142 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe STREET NORTH EAST LIMITED ?
| Adresse du siège social | 3rd Floor Baltimore House Abbotts Hill NE8 3DF Gateshead |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de STREET NORTH EAST LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2015 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour STREET NORTH EAST LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour STREET NORTH EAST LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2015 | 14 pages | AA | ||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 mars 2015 sans liste des membres | 4 pages | AR01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen John Lightley le 01 mars 2015 | 2 pages | CH01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Floor 10 Baltic Place West South Shore Road Gateshead Tyne and Wear NE8 3AE à 3Rd Floor Baltimore House Abbotts Hill Gateshead NE8 3DF le 02 mars 2015 | 2 pages | AD01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2014 | 11 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de First Floor Media 5 the Media Exchange Coquet Street Ouseburn Valley Newcastle upon Tyne NE1 2QB à Floor 10 Baltic Place West South Shore Road Gateshead Tyne and Wear NE8 3AE le 30 déc. 2014 | 2 pages | AD01 | ||
Nomination de Mr Stephen John Lightley en tant qu'administrateur le 19 nov. 2014 | 3 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Graham Simon Thrower en tant qu'administrateur le 28 oct. 2014 | 3 pages | AP01 | ||
Nomination de Andrew James Arkless en tant que secrétaire le 28 oct. 2014 | 5 pages | AP03 | ||
Nomination de Mark Anton Chidley en tant qu'administrateur le 28 oct. 2014 | 3 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Neil Kenneth Warwick en tant que directeur le 28 oct. 2014 | 2 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Geoffrey Mark Hodgson en tant qu'administrateur le 28 oct. 2014 | 3 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Daniel Martin Brophy en tant que directeur le 28 oct. 2014 | 2 pages | TM01 | ||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 mars 2014 sans liste des membres | 3 pages | AR01 | ||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 5 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 050861420004 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013 | 10 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de * Portman House Portland Road Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE2 1AQ* le 15 août 2013 | 1 pages | AD01 | ||
Inscription de la charge 050861420004 | 18 pages | MR01 | ||
legacy | 5 pages | MG01 | ||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 mars 2013 sans liste des membres | 3 pages | AR01 | ||
Qui sont les dirigeants de STREET NORTH EAST LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKLESS, Andrew James | Secrétaire | Baltimore House Abbotts Hill NE8 3DF Gateshead 3rd Floor | British | 192657480001 | ||||||
| CHIDLEY, Mark Anton | Administrateur | Baltimore House Abbotts Hill NE8 3DF Gateshead 3rd Floor | United Kingdom | British | 8085410001 | |||||
| HODGSON, Geoffrey Mark | Administrateur | Baltimore House Abbotts Hill NE8 3DF Gateshead 3rd Floor | United Kingdom | British | 141886470001 | |||||
| LIGHTLEY, Stephen John | Administrateur | Baltimore House Abbotts Hill NE8 3DF Gateshead 3rd Floor | United Kingdom | British | 47296680002 | |||||
| THROWER, Graham Simon | Administrateur | Baltimore House Abbotts Hill NE8 3DF Gateshead 3rd Floor | England | British | 122421340001 | |||||
| GOLD, Howard Barry | Secrétaire | 29 Montagu Avenue Gosforth NE3 4JH Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 77597900001 | ||||||
| HALL, John Andrew | Secrétaire | 5 Briar Avenue NE26 1RU Whitley Bay Tyne & Wear | British | 96872370001 | ||||||
| KINCAID, Laura Mary Ann | Secrétaire | Wheatfields Seaton Delaval NE25 0PZ Whitley Bay 38 Tyne And Wear | British | 140090460001 | ||||||
| LOUW, Joan Eileen | Secrétaire | Portland Road NE2 1AQ Newcastle Upon Tyne Portman House Tyne And Wear United Kingdom | British | 155255120001 | ||||||
| SMITH, Nigel | Secrétaire | Carnoustie Close NE63 9GB Ashington 19 Northumberland | British | 133942520001 | ||||||
| @UKPLC CLIENT SECRETARY LTD | Secrétaire désigné | 5, Jupiter House Calleva Park, Aldermaston RG7 8NN Reading | 900025730001 | |||||||
| BROPHY, Daniel Martin | Administrateur | The Grove Gosforth NE3 1NX Newcastle Upon Tyne 8 United Kingdom | England | British | 63067480002 | |||||
| COCKSEDGE, Susan | Administrateur | Northumberland Terrace NE30 4BA Tynemouth 3 Tyne And Wear | United Kingdom | British | 137822240001 | |||||
| DUFFY, Jill Angela | Administrateur | Earnshaw Way NE25 9UL Whitley Bay 39 Tyne And Wear | United Kingdom | British | 136717840001 | |||||
| GOLD, Howard Barry | Administrateur | 29 Montagu Avenue Gosforth NE3 4JH Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 77597900001 | |||||
| HALL, John Andrew | Administrateur | 5 Briar Avenue NE26 1RU Whitley Bay Tyne & Wear | British | 96872370001 | ||||||
| HAVERS, Mark Charles | Administrateur | Browney House Quarry House Lane DH1 4JA Durham | England | British | 98277670002 | |||||
| HOCKLY, Martin Kenneth | Administrateur | 38 Coppice Road Moseley B13 9DP Birmingham West Midlands | England | British | 102962560001 | |||||
| KAY, Fiona Jane | Administrateur | Wydon Burn Cottage Causey Hill NE46 2JG Hexham Northumberland | United Kingdom | British | 106725620001 | |||||
| KING, Sandra | Administrateur | 5 Trewhitt Road NE6 5LT Newcastle Tyne & Wear | United Kingdom | British | 79015270001 | |||||
| MIDGLEY, David William | Administrateur | 17 Beaumont Drive Beaumont Park NE25 9UT Whitley Bay Tyne & Wear | United Kingdom | British | 4510810001 | |||||
| RIDLEY, Jane | Administrateur | Coniscliffe Road DL3 7RW Darlington 96 Co Durham | United Kingdom | British | 139539810001 | |||||
| SMITH, Nigel | Administrateur | Carnoustie Close NE63 9GB Ashington 19 Northumberland | British | 133942520001 | ||||||
| WARWICK, Neil Kenneth | Administrateur | The Media Exchange Coquet Street Ouseburn Valley NE1 2QB Newcastle Upon Tyne First Floor Media 5 England | United Kingdom | British | 141928730002 | |||||
| WELCH, Katherine Margaret | Administrateur | Kingsmere DH3 4DE Chester Le Street 108 County Durham | England | British | 83820080001 | |||||
| @UKPLC CLIENT DIRECTOR LTD | Administrateur désigné | 5, Jupiter House Calleva Park, Aldermaston RG7 8NN Reading | 900025720001 |
STREET NORTH EAST LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 17 juil. 2013 Livré le 18 juil. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Assignment over loan portfolio. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignment | Créé le 28 mars 2013 Livré le 05 avr. 2013 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All rights title and interest in and under the loan offers including all right title and interest in respect of the debts and the proceeds of any enforcement of security under any of the security documents see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 15 mars 2013 Livré le 16 mars 2013 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 19 juin 2007 Livré le 23 juin 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0