STREET NORTH EAST LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTREET NORTH EAST LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société 05086142
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STREET NORTH EAST LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe STREET NORTH EAST LIMITED ?

    Adresse du siège social
    3rd Floor Baltimore House
    Abbotts Hill
    NE8 3DF Gateshead
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de STREET NORTH EAST LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour STREET NORTH EAST LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour STREET NORTH EAST LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 mars 2015 sans liste des membres

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen John Lightley le 01 mars 2015

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Floor 10 Baltic Place West South Shore Road Gateshead Tyne and Wear NE8 3AE à 3Rd Floor Baltimore House Abbotts Hill Gateshead NE8 3DF le 02 mars 2015

    2 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2014

    11 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de First Floor Media 5 the Media Exchange Coquet Street Ouseburn Valley Newcastle upon Tyne NE1 2QB à Floor 10 Baltic Place West South Shore Road Gateshead Tyne and Wear NE8 3AE le 30 déc. 2014

    2 pagesAD01

    Nomination de Mr Stephen John Lightley en tant qu'administrateur le 19 nov. 2014

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr Graham Simon Thrower en tant qu'administrateur le 28 oct. 2014

    3 pagesAP01

    Nomination de Andrew James Arkless en tant que secrétaire le 28 oct. 2014

    5 pagesAP03

    Nomination de Mark Anton Chidley en tant qu'administrateur le 28 oct. 2014

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Neil Kenneth Warwick en tant que directeur le 28 oct. 2014

    2 pagesTM01

    Nomination de Mr Geoffrey Mark Hodgson en tant qu'administrateur le 28 oct. 2014

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Daniel Martin Brophy en tant que directeur le 28 oct. 2014

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 mars 2014 sans liste des membres

    3 pagesAR01

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    5 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 050861420004 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013

    10 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * Portman House Portland Road Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE2 1AQ* le 15 août 2013

    1 pagesAD01

    Inscription de la charge 050861420004

    18 pagesMR01

    legacy

    5 pagesMG01

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 mars 2013 sans liste des membres

    3 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de STREET NORTH EAST LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ARKLESS, Andrew James
    Baltimore House
    Abbotts Hill
    NE8 3DF Gateshead
    3rd Floor
    Secrétaire
    Baltimore House
    Abbotts Hill
    NE8 3DF Gateshead
    3rd Floor
    British192657480001
    CHIDLEY, Mark Anton
    Baltimore House
    Abbotts Hill
    NE8 3DF Gateshead
    3rd Floor
    Administrateur
    Baltimore House
    Abbotts Hill
    NE8 3DF Gateshead
    3rd Floor
    United KingdomBritish8085410001
    HODGSON, Geoffrey Mark
    Baltimore House
    Abbotts Hill
    NE8 3DF Gateshead
    3rd Floor
    Administrateur
    Baltimore House
    Abbotts Hill
    NE8 3DF Gateshead
    3rd Floor
    United KingdomBritish141886470001
    LIGHTLEY, Stephen John
    Baltimore House
    Abbotts Hill
    NE8 3DF Gateshead
    3rd Floor
    Administrateur
    Baltimore House
    Abbotts Hill
    NE8 3DF Gateshead
    3rd Floor
    United KingdomBritish47296680002
    THROWER, Graham Simon
    Baltimore House
    Abbotts Hill
    NE8 3DF Gateshead
    3rd Floor
    Administrateur
    Baltimore House
    Abbotts Hill
    NE8 3DF Gateshead
    3rd Floor
    EnglandBritish122421340001
    GOLD, Howard Barry
    29 Montagu Avenue
    Gosforth
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    29 Montagu Avenue
    Gosforth
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British77597900001
    HALL, John Andrew
    5 Briar Avenue
    NE26 1RU Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    5 Briar Avenue
    NE26 1RU Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British96872370001
    KINCAID, Laura Mary Ann
    Wheatfields
    Seaton Delaval
    NE25 0PZ Whitley Bay
    38
    Tyne And Wear
    Secrétaire
    Wheatfields
    Seaton Delaval
    NE25 0PZ Whitley Bay
    38
    Tyne And Wear
    British140090460001
    LOUW, Joan Eileen
    Portland Road
    NE2 1AQ Newcastle Upon Tyne
    Portman House
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Secrétaire
    Portland Road
    NE2 1AQ Newcastle Upon Tyne
    Portman House
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    British155255120001
    SMITH, Nigel
    Carnoustie Close
    NE63 9GB Ashington
    19
    Northumberland
    Secrétaire
    Carnoustie Close
    NE63 9GB Ashington
    19
    Northumberland
    British133942520001
    @UKPLC CLIENT SECRETARY LTD
    5, Jupiter House
    Calleva Park, Aldermaston
    RG7 8NN Reading
    Secrétaire désigné
    5, Jupiter House
    Calleva Park, Aldermaston
    RG7 8NN Reading
    900025730001
    BROPHY, Daniel Martin
    The Grove
    Gosforth
    NE3 1NX Newcastle Upon Tyne
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    The Grove
    Gosforth
    NE3 1NX Newcastle Upon Tyne
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish63067480002
    COCKSEDGE, Susan
    Northumberland Terrace
    NE30 4BA Tynemouth
    3
    Tyne And Wear
    Administrateur
    Northumberland Terrace
    NE30 4BA Tynemouth
    3
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish137822240001
    DUFFY, Jill Angela
    Earnshaw Way
    NE25 9UL Whitley Bay
    39
    Tyne And Wear
    Administrateur
    Earnshaw Way
    NE25 9UL Whitley Bay
    39
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish136717840001
    GOLD, Howard Barry
    29 Montagu Avenue
    Gosforth
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    29 Montagu Avenue
    Gosforth
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish77597900001
    HALL, John Andrew
    5 Briar Avenue
    NE26 1RU Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Administrateur
    5 Briar Avenue
    NE26 1RU Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British96872370001
    HAVERS, Mark Charles
    Browney House
    Quarry House Lane
    DH1 4JA Durham
    Administrateur
    Browney House
    Quarry House Lane
    DH1 4JA Durham
    EnglandBritish98277670002
    HOCKLY, Martin Kenneth
    38 Coppice Road
    Moseley
    B13 9DP Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    38 Coppice Road
    Moseley
    B13 9DP Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish102962560001
    KAY, Fiona Jane
    Wydon Burn Cottage
    Causey Hill
    NE46 2JG Hexham
    Northumberland
    Administrateur
    Wydon Burn Cottage
    Causey Hill
    NE46 2JG Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritish106725620001
    KING, Sandra
    5 Trewhitt Road
    NE6 5LT Newcastle
    Tyne & Wear
    Administrateur
    5 Trewhitt Road
    NE6 5LT Newcastle
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish79015270001
    MIDGLEY, David William
    17 Beaumont Drive
    Beaumont Park
    NE25 9UT Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Administrateur
    17 Beaumont Drive
    Beaumont Park
    NE25 9UT Whitley Bay
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish4510810001
    RIDLEY, Jane
    Coniscliffe Road
    DL3 7RW Darlington
    96
    Co Durham
    Administrateur
    Coniscliffe Road
    DL3 7RW Darlington
    96
    Co Durham
    United KingdomBritish139539810001
    SMITH, Nigel
    Carnoustie Close
    NE63 9GB Ashington
    19
    Northumberland
    Administrateur
    Carnoustie Close
    NE63 9GB Ashington
    19
    Northumberland
    British133942520001
    WARWICK, Neil Kenneth
    The Media Exchange
    Coquet Street Ouseburn Valley
    NE1 2QB Newcastle Upon Tyne
    First Floor Media 5
    England
    Administrateur
    The Media Exchange
    Coquet Street Ouseburn Valley
    NE1 2QB Newcastle Upon Tyne
    First Floor Media 5
    England
    United KingdomBritish141928730002
    WELCH, Katherine Margaret
    Kingsmere
    DH3 4DE Chester Le Street
    108
    County Durham
    Administrateur
    Kingsmere
    DH3 4DE Chester Le Street
    108
    County Durham
    EnglandBritish83820080001
    @UKPLC CLIENT DIRECTOR LTD
    5, Jupiter House
    Calleva Park, Aldermaston
    RG7 8NN Reading
    Administrateur désigné
    5, Jupiter House
    Calleva Park, Aldermaston
    RG7 8NN Reading
    900025720001

    STREET NORTH EAST LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 17 juil. 2013
    Livré le 18 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Assignment over loan portfolio.
    Personnes ayant droit
    • Unity Trust Bank PLC
    Transactions
    • 18 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 12 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment
    Créé le 28 mars 2013
    Livré le 05 avr. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights title and interest in and under the loan offers including all right title and interest in respect of the debts and the proceeds of any enforcement of security under any of the security documents see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Unity Trust Bank PLC
    Transactions
    • 05 avr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 15 mars 2013
    Livré le 16 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Unity Trust Bank PLC
    Transactions
    • 16 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 19 juin 2007
    Livré le 23 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Northern Rock Foundation
    Transactions
    • 23 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0