STONE GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTONE GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05088374
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STONE GROUP LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe STONE GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Granite One Hundred
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Staffordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STONE GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GW 3126 LIMITED30 mars 200430 mars 2004

    Quels sont les derniers comptes de STONE GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour STONE GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré One Eleven Edmund Street Birmingham B3 2HJ

    1 pagesAD03

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 mai 2016

    État du capital au 12 mai 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Granite One Hundred Acton Gate Stafford Staffordshire ST18 9AA

    1 pagesAD04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    38 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 17 août 2015

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 mai 2015

    État du capital au 29 mai 2015

    • Capital: GBP 1,252,377
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Simon Richard Harbridge le 06 mars 2015

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 juin 2014

    État du capital au 04 juin 2014

    • Capital: GBP 1,252,377
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Simon Richard Harbridge le 03 mai 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Peter Reginald Berks le 03 mai 2014

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de * 18 Chalfont Road Maplecross Rickmansworth WD3 9TB* le 04 juin 2014

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    13 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 33 Whitecroft Road Luton Bedfordshire LU2 0JS* le 08 août 2013

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * Granite One Hundred Acton Gate Stafford Staffordshire ST18 9AA* le 19 juin 2013

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Peter Reginald Berks le 03 mai 2013

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de STONE GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CONSTANTINIDES, Sotos
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    United Kingdom
    British176573280001
    BERKS, Peter Reginald
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish141072000001
    CONSTANTINIDES, Sotos
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish124622460002
    HARBRIDGE, Simon Richard
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish105161460006
    BIRCH, Elizabeth
    15 Nursery Way
    ST18 0FY Great Haywood
    Staffordshire
    Secrétaire
    15 Nursery Way
    ST18 0FY Great Haywood
    Staffordshire
    British105161330001
    HARBRIDGE, Simon Richard
    Marlbrook Lane
    Sale Green
    WR9 7LW Droitwich
    Charlbury House
    Worcestershire
    Secrétaire
    Marlbrook Lane
    Sale Green
    WR9 7LW Droitwich
    Charlbury House
    Worcestershire
    British105161460002
    GW SECRETARIES LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    93128710001
    BIRD, Ronald James
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    Administrateur
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    UkBritish129727420002
    CAPEWELL, Colin John
    Allens Croft
    Marchington
    ST14 8PX Uttoxeter
    7
    Staffordshire
    Administrateur
    Allens Croft
    Marchington
    ST14 8PX Uttoxeter
    7
    Staffordshire
    EnglandBritish138766880001
    HARRISON, Anthony James
    11 Attingham Drive
    WS11 2YB Cannock
    Staffordshire
    Administrateur
    11 Attingham Drive
    WS11 2YB Cannock
    Staffordshire
    British67231170001
    KAZEROUNIAN, Seyed Abdul Reza
    73a Hartwell Road
    Long Street Hanslope
    MK19 7BY Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    73a Hartwell Road
    Long Street Hanslope
    MK19 7BY Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritish118333280001
    MATTHEWS, Richard
    30 Darnford Moors
    WS14 9RL Lichfield
    Administrateur
    30 Darnford Moors
    WS14 9RL Lichfield
    United KingdomBritish58335840002
    PETTIT, Simon
    Church View Barn
    ST20 0QB Adbaston
    Staffordshire
    Administrateur
    Church View Barn
    ST20 0QB Adbaston
    Staffordshire
    United KingdomBritish184217030001
    RUSSELL, James
    34 Hazel Avenue
    WR11 1XT Eavesham
    Worcestershire
    Administrateur
    34 Hazel Avenue
    WR11 1XT Eavesham
    Worcestershire
    United KingdomBritish111890860001
    TEMPLE, John
    3 Victoria Crescent
    Queens Park
    CH4 7AX Chester
    Administrateur
    3 Victoria Crescent
    Queens Park
    CH4 7AX Chester
    British62721620002
    WILCOX, David Alan
    76 Wellington Road
    Muxton
    TF2 8NZ Telford
    Shropshire
    Administrateur
    76 Wellington Road
    Muxton
    TF2 8NZ Telford
    Shropshire
    EnglandBritish61124810003
    GW INCORPORATIONS LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    68279000003

    STONE GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Accession deed
    Créé le 04 avr. 2008
    Livré le 10 avr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 10 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 23 janv. 2007
    Livré le 31 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Simon Harbridge (The Lender)
    Transactions
    • 31 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 janv. 2007
    Livré le 31 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • David Wilcox (The Lender)
    Transactions
    • 31 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 janv. 2007
    Livré le 31 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jamie Russell (The Lender)
    Transactions
    • 31 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 janv. 2007
    Livré le 31 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anthony James Harrison (The Lender)
    Transactions
    • 31 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 janv. 2007
    Livré le 31 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Stephen Grocott and Philip Taylor, as Trustee for the Ron Bird Discretionary Trust (The Lender)
    Transactions
    • 31 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Own account assignment of life policy
    Créé le 03 févr. 2005
    Livré le 19 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Policy number H181681501 bupa health assurance limited on the life of richard matthews together with all amounts (including bonuses) to be paid under it. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Own account assignment of life policy
    Créé le 03 févr. 2005
    Livré le 19 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Policy number H181676701 bupa health assurance limited on the life of david wilcox together with all amounts (including bonuses) to be paid under it. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 févr. 2005
    Livré le 19 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 03 févr. 2005
    Livré le 19 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the right,title and interest of the company in and to the acquisition agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Own account assignment of life policy
    Créé le 03 févr. 2005
    Livré le 19 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Policy number H181691201 bupa health assurance limited on the life of anthony harrison together with all amounts (including bonuses) to be paid under it. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Own account assignment of life policy
    Créé le 03 févr. 2005
    Livré le 19 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Policy number H181686401 bupa health assurance limited life assured simon petit together with all amounts (including bonuses) to be paid under it. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 03 févr. 2005
    Livré le 08 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the investors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a omega house emerald way stone business park emerald way stone staffordshire t/no SFZ593945. All other property and all interests in property, all computers vehicles office equipment, all charged securities, the security accounts, the intellectual property, the benefit of licences and the goodwill and uncalled capital. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cavendish Nominees Limited
    Transactions
    • 08 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0