HCCAH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHCCAH LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05096889
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HCCAH LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe HCCAH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Inspire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    North Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HCCAH LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALEXANDRA HOUSE PROPERTIES LIMITED01 juin 200401 juin 2004
    TRUSHELFCO (NO.3043) LIMITED06 avr. 200406 avr. 2004

    Quels sont les derniers comptes de HCCAH LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HCCAH LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour HCCAH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Mr James Alexander Burrell en tant qu'administrateur le 10 nov. 2014

    2 pagesAP01

    Comptes établis au 31 déc. 2013

    1 pagesAA

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Inscription de la charge 050968890008, créée le 12 juin 2014

    91 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 avr. 2014

    État du capital au 07 avr. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Mrs Geraldine Josephine Gallagher en tant qu'administrateur le 31 janv. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Matthew Edward Bennison en tant que directeur le 31 janv. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Matthew Edward Bennison en tant que secrétaire le 31 janv. 2014

    1 pagesTM02

    Comptes établis au 31 déc. 2012

    1 pagesAA

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Résolutions

    Resolutions
    11 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    18 pagesMG01

    Comptes établis au 31 déc. 2011

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    legacy

    14 pagesMG01

    Comptes établis au 31 déc. 2010

    1 pagesAA

    Nomination de Mr Matthew Edward Bennison en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Matthew Edward Bennison en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Timothy Doubleday en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de HCCAH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BURRELL, James Alexander
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Administrateur
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United KingdomBritish192486560001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandIrish185108770001
    HUNTER, Gail Susan
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish89557480002
    TROY, Anthony Gerard
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomIrish104500230001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    161805270001
    DOUBLEDAY, Timothy
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    British156121500001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Irish185108770001
    SOLOMAN, Sheila Margaret
    5 The Green
    Hardingstone
    NN4 7BU Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    5 The Green
    Hardingstone
    NN4 7BU Northampton
    Northamptonshire
    British45253560008
    TRUSEC LIMITED
    2 Lambs Passage
    EC1Y 8BB London
    Secrétaire désigné
    2 Lambs Passage
    EC1Y 8BB London
    900007200001
    ANDERSON, Peter George
    23 Cheshire Road
    OX9 3LQ Thame
    Oxfordshire
    Administrateur
    23 Cheshire Road
    OX9 3LQ Thame
    Oxfordshire
    British70304810001
    BELLONE, Norman Edward
    Gardens Cottage
    Bagendon
    GL7 7DU Cirencester
    Gloucestershire
    Administrateur
    Gardens Cottage
    Bagendon
    GL7 7DU Cirencester
    Gloucestershire
    British126414070001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish108534390002
    DAY, Mark
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    Administrateur
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    EnglandBritish124446000001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish91011320001
    NISBETT, Paul Sandle
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    EnglandBritish132613500001
    PEEKE, Alexander
    7 Milton Lodge
    Whitton Road
    TW1 1BU Twickenham
    Administrateur
    7 Milton Lodge
    Whitton Road
    TW1 1BU Twickenham
    British98031180001
    STOKER, Louise Jane
    2nd Floor Flat
    45 Hillfield Road, West Hampstead
    NW6 1QD London
    Administrateur
    2nd Floor Flat
    45 Hillfield Road, West Hampstead
    NW6 1QD London
    British96079800001
    WHITE, Graham Peter
    Copsem Lane
    KT22 0NT Oxshott
    Woodlands House
    Surrey
    Administrateur
    Copsem Lane
    KT22 0NT Oxshott
    Woodlands House
    Surrey
    United KingdomBritish4934020002
    ZUERCHER, Eleanor Jane
    14 St Marys Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    14 St Marys Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Buckinghamshire
    British61053330001

    HCCAH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 12 juin 2014
    Livré le 18 juin 2014
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transactions
    • 18 juin 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    English law deed of accession
    Créé le 27 févr. 2013
    Livré le 01 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transactions
    • 01 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 27 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 01 déc. 2011
    Livré le 10 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession
    Créé le 18 juin 2007
    Livré le 22 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 31 mars 2006
    Livré le 06 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as 'Security Agent'
    Transactions
    • 06 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession to the composite guarantee and debenture dated 18 december 2003
    Créé le 24 janv. 2005
    Livré le 02 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by each charging company to each of the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Princess alexandra raf hospital, wroughton, nr swindon, wiltshire t/ns WT213965 and WT216467,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transactions
    • 02 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 18 déc. 2003
    Acquis le 24 janv. 2005
    Livré le 27 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each charging company to each of the lenders
    Brèves mentions
    Property k/a alexander house, wroughton, near swindon, wiltshire t/n WT2139665 and WT216467.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transactions
    • 27 janv. 2005Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 04 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 14 janv. 2000
    Acquis le 24 janv. 2005
    Livré le 03 févr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land containing 29.830 hectares or thereabouts situated wroughton swindon wiltshire.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Defence
    Transactions
    • 03 févr. 2005Enregistrement d'une acquisition (400)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0