HCCAH LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HCCAH LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 05096889 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HCCAH LIMITED ?
| Adresse du siège social | The Inspire Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate North Yorkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HCCAH LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HCCAH LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour HCCAH LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Nomination de Mr James Alexander Burrell en tant qu'administrateur le 10 nov. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2013 | 1 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 7 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Inscription de la charge 050968890008, créée le 12 juin 2014 | 91 pages | MR01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mrs Geraldine Josephine Gallagher en tant qu'administrateur le 31 janv. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew Edward Bennison en tant que directeur le 31 janv. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew Edward Bennison en tant que secrétaire le 31 janv. 2014 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2012 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 11 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
legacy | 18 pages | MG01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2011 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
legacy | 14 pages | MG01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2010 | 1 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Matthew Edward Bennison en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Matthew Edward Bennison en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Doubleday en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HCCAH LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURRELL, James Alexander | Administrateur | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | British | 192486560001 | |||||
| GALLAGHER, Geraldine Josephine | Administrateur | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | England | Irish | 185108770001 | |||||
| HUNTER, Gail Susan | Administrateur | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 89557480002 | |||||
| TROY, Anthony Gerard | Administrateur | Fountains Bent Darley Road, Bristwith HG3 2PN Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | Irish | 104500230001 | |||||
| BENNISON, Matthew Edward | Secrétaire | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | 161805270001 | |||||||
| DOUBLEDAY, Timothy | Secrétaire | Hornbeam Park HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | British | 156121500001 | ||||||
| GALLAGHER, Geraldine Josephine | Secrétaire | Risplith House HG4 3EP Risplith North Yorkshire | Irish | 185108770001 | ||||||
| SOLOMAN, Sheila Margaret | Secrétaire | 5 The Green Hardingstone NN4 7BU Northampton Northamptonshire | British | 45253560008 | ||||||
| TRUSEC LIMITED | Secrétaire désigné | 2 Lambs Passage EC1Y 8BB London | 900007200001 | |||||||
| ANDERSON, Peter George | Administrateur | 23 Cheshire Road OX9 3LQ Thame Oxfordshire | British | 70304810001 | ||||||
| BELLONE, Norman Edward | Administrateur | Gardens Cottage Bagendon GL7 7DU Cirencester Gloucestershire | British | 126414070001 | ||||||
| BENNISON, Matthew Edward | Administrateur | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | England | British | 108534390002 | |||||
| DAY, Mark | Administrateur | Welton Hill Kidd Lane HU15 1PH Welton Brough North Humberside | England | British | 124446000001 | |||||
| DOUBLEDAY, Timothy John | Administrateur | Hornbeam Park HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 91011320001 | |||||
| NISBETT, Paul Sandle | Administrateur | The Grove Bletchley MK3 6BZ Milton Keynes 5 Buckinghamshire | England | British | 132613500001 | |||||
| PEEKE, Alexander | Administrateur | 7 Milton Lodge Whitton Road TW1 1BU Twickenham | British | 98031180001 | ||||||
| STOKER, Louise Jane | Administrateur | 2nd Floor Flat 45 Hillfield Road, West Hampstead NW6 1QD London | British | 96079800001 | ||||||
| WHITE, Graham Peter | Administrateur | Copsem Lane KT22 0NT Oxshott Woodlands House Surrey | United Kingdom | British | 4934020002 | |||||
| ZUERCHER, Eleanor Jane | Administrateur | 14 St Marys Court Tingewick MK18 4RE Buckingham Buckinghamshire | British | 61053330001 |
HCCAH LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 12 juin 2014 Livré le 18 juin 2014 | En cours | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| English law deed of accession | Créé le 27 févr. 2013 Livré le 01 mars 2013 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 01 déc. 2011 Livré le 10 déc. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of accession | Créé le 18 juin 2007 Livré le 22 juin 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 31 mars 2006 Livré le 06 avr. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of accession to the composite guarantee and debenture dated 18 december 2003 | Créé le 24 janv. 2005 Livré le 02 févr. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due by each charging company to each of the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Princess alexandra raf hospital, wroughton, nr swindon, wiltshire t/ns WT213965 and WT216467,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 18 déc. 2003 Acquis le 24 janv. 2005 Livré le 27 janv. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each charging company to each of the lenders | |
Brèves mentions Property k/a alexander house, wroughton, near swindon, wiltshire t/n WT2139665 and WT216467. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 14 janv. 2000 Acquis le 24 janv. 2005 Livré le 03 févr. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Land containing 29.830 hectares or thereabouts situated wroughton swindon wiltshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0