COLERIDGE (NO. 32) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOLERIDGE (NO. 32) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05099199
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COLERIDGE (NO. 32) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe COLERIDGE (NO. 32) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COLERIDGE (NO. 32) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    COLERIDGE (NO. 30) LIMITED08 avr. 200408 avr. 2004

    Quels sont les derniers comptes de COLERIDGE (NO. 32) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour COLERIDGE (NO. 32) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    43 pages4.71

    Cessation de la nomination de Neil Kenneth Robertson en tant que directeur le 24 févr. 2017

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU à The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG le 11 avr. 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 22 mars 2016

    LRESSP

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015

    3 pagesAA

    Nomination de Mr Neil Kenneth Robertson en tant qu'administrateur le 05 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Claire Treacy en tant que directeur le 05 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Claire Treacy en tant qu'administrateur le 14 août 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Fraser James Kennedy en tant que directeur le 14 août 2015

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 avr. 2015

    État du capital au 10 avr. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 avr. 2014

    État du capital au 11 avr. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013

    3 pagesAA

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Valsec Director Limited le 01 juil. 2013

    2 pagesCH02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Fraser James Kennedy le 01 juil. 2013

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de * Europa House 20 Esplanade Scarborough YO11 2AQ* le 02 juil. 2013

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de COLERIDGE (NO. 32) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Secrétaire
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC219311
    133355520001
    VALSEC DIRECTOR LIMITED
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5307786
    102622300002
    ADAM, Jessica Helen
    30 Barrington Court
    Colney Hatch Lane
    N10 1QG London
    Secrétaire
    30 Barrington Court
    Colney Hatch Lane
    N10 1QG London
    British96990150001
    ADAM, Jessica Helen
    30 Barrington Court
    Colney Hatch Lane
    N10 1QG London
    Administrateur
    30 Barrington Court
    Colney Hatch Lane
    N10 1QG London
    BritishSolicitor96990150001
    BLAKE, Walter
    23 Saint Peters Place
    EH3 9PQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    23 Saint Peters Place
    EH3 9PQ Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor95723070001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritishSolicitor1267050001
    KENNEDY, Fraser James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant121610350003
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    BritishChartered Surveyor109250000001
    OKUNOLA, Abayomi Abiodun
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector135717740001
    ROBERTSON, Neil Kenneth
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant158937210001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Administrateur
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritishChartered Accountant41925000003
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Administrateur
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritishChartered Surveyor69909950001
    TREACY, Claire
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrishHead Of Tax & Risk, Europe189529610001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001

    COLERIDGE (NO. 32) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 22 mars 2012
    Livré le 30 mars 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 30 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession and charge
    Créé le 28 août 2009
    Livré le 11 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the charging company’s and any other chargor’s indebtedness to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All land in england and wales,all its rights at the accession deed date,all trade debts and other debts see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Secured Parties)
    Transactions
    • 11 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 29 juil. 2005
    Livré le 13 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in the security assets being the units in the trust specified in the agreement and all related rights,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 07 oct. 2004
    Livré le 15 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Springpark house basing view basingstoke hampshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 29 juil. 2004
    Livré le 06 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    COLERIDGE (NO. 32) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 mars 2016Commencement of winding up
    30 juil. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    practitioner
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Geoffrey Wayne Bouchier
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    practitioner
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0