RICHMOND CARE VILLAGES HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | RICHMOND CARE VILLAGES HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 05105798 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RICHMOND CARE VILLAGES HOLDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 Angel Court EC2R 7HJ London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RICHMOND CARE VILLAGES HOLDINGS LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour RICHMOND CARE VILLAGES HOLDINGS LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 20 juin 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 04 juil. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 20 juin 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour RICHMOND CARE VILLAGES HOLDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neil Stephen Barker le 08 déc. 2025 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2024 | 24 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rebecca Pearson en tant que directeur le 03 févr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Thomas Nichol Hoosen-Webber en tant qu'administrateur le 03 févr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 28 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 30 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Harrison en tant que directeur le 31 juil. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Rebecca Pearson le 31 janv. 2022 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Philippa Jane Kellar le 06 sept. 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 27 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Philippa Jane Fieldhouse le 11 mai 2022 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2022 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 29 nov. 2021
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 29 nov. 2021
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 28 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mrs Rebecca Pearson en tant qu'administrateur le 02 juil. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Joan Martina Elliott en tant que directeur le 02 juil. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Aileen Waton en tant qu'administrateur le 18 mars 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 26 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Charles Austen Richardson en tant que directeur le 14 août 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de RICHMOND CARE VILLAGES HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPA SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom |
| 162768400001 | ||||||||||
| BARKER, Neil Stephen | Administrateur | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | England | British | 159087650002 | |||||||||
| HOOSEN-WEBBER, Thomas Nichol | Administrateur | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | England | British | 249384870003 | |||||||||
| KELLAR, Philippa Jane | Administrateur | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | England | British | 184089500005 | |||||||||
| WATON, Aileen | Administrateur | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | Scotland | British | 237290130001 | |||||||||
| DUNCAN, David Gregor | Secrétaire | Flat 43 The Piper Building Peterborough Road SW6 3EF London | British | 97755760001 | ||||||||||
| HATHER, Jon | Secrétaire | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | British | 68848420004 | ||||||||||
| PORTAL, Ian | Secrétaire | Suite 201, The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London | British | 164886520001 | ||||||||||
| RICHARDSON, Joanne | Secrétaire | Outwood Lane LS18 4UP Leeds Bridge House | 177616680001 | |||||||||||
| PAILEX SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 20 Bedford Row WC1R 4JS London | 74551790001 | |||||||||||
| BARTON, Catherine Elizabeth | Administrateur | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 206964340002 | |||||||||
| BATESON, John Gerard | Administrateur | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | Ireland | Irish | 118894220001 | |||||||||
| BOWDEN, Richard Thomas | Administrateur | Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House 15-19 United Kingdom | United Kingdom | Australian | 172827550002 | |||||||||
| BRICE, Paddy | Administrateur | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 117415010002 | |||||||||
| BROSNAN, Denis | Administrateur | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | Ireland | Irish | 142998660001 | |||||||||
| BROSNAN, Denis | Administrateur | Croom House Croom Croom County Limerick Ireland | Ireland | Irish | 142998660001 | |||||||||
| CANNON, Andrew John | Administrateur | Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House 15-19 United Kingdom | England | British | 200461360001 | |||||||||
| COCKELL, Keith Henry | Administrateur | Old Mill Farm Back Lane Upper Oddington GL56 0XL Moreton On Marsh Gloucestershire | United Kingdom | British | 162548990001 | |||||||||
| DUNCAN, David Gregor | Administrateur | Flat 43 The Piper Building Peterborough Road SW6 3EF London | United Kingdom | British | 97755760001 | |||||||||
| ELLIOTT, Joan Martina | Administrateur | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | England | British | 309829120001 | |||||||||
| GRIFFIN, Michael | Administrateur | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | England | Irish | 122468450002 | |||||||||
| HARRISON, Michael | Administrateur | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 241166230001 | |||||||||
| HUGHES, John Craig | Administrateur | Lansdowne Crescent W11 2NT London 41a | United Kingdom | Us | 84916320001 | |||||||||
| HYNAM, David Emmanuel | Administrateur | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | England | British | 92485410001 | |||||||||
| IRWIN, Edward Joseph | Administrateur | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | Ireland | Irish | 36570270002 | |||||||||
| JACKSON, Paul | Administrateur | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 135682290003 | |||||||||
| MCELROY, Eamon Francis | Administrateur | Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 The Chambers | Ireland | British | 150585350001 | |||||||||
| MCELROY, Eamon Francis | Administrateur | 26 Howth Lodge IRISH Howth County Dublin Ireland | Ireland | British | 150585350001 | |||||||||
| MCGARTOLL, Owen Raphael | Administrateur | 58 The Anchorage, Clarence Street IRISH Dun Laoghaire County Dublin Ireland | Irish | 116537370001 | ||||||||||
| MCGARTOLL, Owen Raphael | Administrateur | 58 The Anchorage, Clarence Street IRISH Dun Laoghaire County Dublin Ireland | Irish | 116537370001 | ||||||||||
| MCGARTOLL, Owen Raphael | Administrateur | 58 The Anchorage, Clarence Street IRISH Dun Laoghaire County Dublin Ireland | Irish | 116537370001 | ||||||||||
| MOORE, Keith | Administrateur | Outwood Lane Horsforth LS18 4UP Leeds Bridge House Yorkshire Uk | United Kingdom | British | 49217290002 | |||||||||
| MURPHY, Paul Edward | Administrateur | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | Ireland | Irish | 104969070004 | |||||||||
| PARSONS, Michael Dennis | Administrateur | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 44895330007 | |||||||||
| PEARSON, Rebecca | Administrateur | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 245936140002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RICHMOND CARE VILLAGES HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bupa Finance Plc | 22 juin 2016 | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Bupa Care Homes (Ans) Limited | 06 avr. 2016 | Outwood Lane Horsforth LS18 4UP Leeds Bridge House United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0